TOUCH GROUP PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOUCH GROUP PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03407323
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOUCH GROUP PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova TOUCH GROUP PLC?

    Indirizzo della sede legale
    c/o DAVID RUBIN & PARTNERS
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOUCH GROUP PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AMBIENT PLC25 ago 199925 ago 1999
    AMBIENT MEDIA CORPORATION PLC23 lug 199723 lug 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOUCH GROUP PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per TOUCH GROUP PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 ago 2015

    14 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 ago 2014

    14 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 ago 2013

    14 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    28 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * Saffron House 6-10 Kirby Street London EC1N 8TS* in data 26 lug 2012

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Robert Lorenz come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Brown come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel ord £0.01 shares from trading on aim 14/12/2011
    RES13

    legacy

    6 pagineMG01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2011

    44 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2011 con elenco di azionisti in blocco

    19 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 ago 2011

    Stato del capitale al 23 ago 2011

    • Capitale: GBP 2,101,919.21
    SH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 feb 2011

    • Capitale: GBP 1,618,585.88
    3 pagineSH01

    legacy

    5 pagineMG01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    1 pagineCC04

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2010

    43 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    71 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2010 con elenco di azionisti in blocco

    19 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Chi sono gli amministratori di TOUCH GROUP PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KATZ, Peter David
    Apartment 8 Alexandra House
    Richmond Drive
    IG8 8RF Woodford Green
    Essex
    Segretario
    Apartment 8 Alexandra House
    Richmond Drive
    IG8 8RF Woodford Green
    Essex
    British64682050002
    GREEN, Timothy Charles
    204a Edwin Road
    ME8 0JL Gillingham
    Kent
    Amministratore
    204a Edwin Road
    ME8 0JL Gillingham
    Kent
    BritishDirector126717770001
    ISAACS, Vincent Joseph
    The Penthouse Flat 7 The Heaths
    61 West Heath Road
    NW3 7TH London
    Amministratore
    The Penthouse Flat 7 The Heaths
    61 West Heath Road
    NW3 7TH London
    United KingdomBritishDirector38705920003
    KATZ, Peter David
    Apartment 8 Alexandra House
    Richmond Drive
    IG8 8RF Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    Apartment 8 Alexandra House
    Richmond Drive
    IG8 8RF Woodford Green
    Essex
    EnglandBritishDirector64682050002
    WINSHIP, Stuart
    Flat 2 Marie Carlile Coley Avenue
    GU22 7RG Woking
    Surrey
    Amministratore
    Flat 2 Marie Carlile Coley Avenue
    GU22 7RG Woking
    Surrey
    EnglandBritishDirector107388320002
    ARNOLD, Michael
    Dormer Cottage
    The Chase Kingswood
    KT20 6HY Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    Dormer Cottage
    The Chase Kingswood
    KT20 6HY Tadworth
    Surrey
    United KingdomBritishConsulting Actuary1399970001
    ASHLEY, Paul Martyn
    10 Wythburn Court
    Seymour Place
    W1H 7NS London
    Amministratore
    10 Wythburn Court
    Seymour Place
    W1H 7NS London
    EnglandBritishDirector35065720001
    BEERLING, Kevin
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Amministratore
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    EnglandBritishDirector64677850002
    BERKIN, Sukru Emre
    Koybasi Cad 257
    Yenikoy
    FOREIGN Istanbul
    Turkey
    Amministratore
    Koybasi Cad 257
    Yenikoy
    FOREIGN Istanbul
    Turkey
    TurkishBusiness Executive108708690001
    BRIER, Timothy
    202 Dans Highway
    CT 06840 New Canaan
    Usa
    Amministratore
    202 Dans Highway
    CT 06840 New Canaan
    Usa
    AmericanDirector70808490001
    BROWN, Neil Graeme
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector49772410001
    CARBY, Keith Arthur
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    The Tri Centre
    Wiltshire
    Amministratore
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    The Tri Centre
    Wiltshire
    BritishDirector12732100004
    DREW, Darren Paul
    14 Beech Road
    TN13 1YG Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    14 Beech Road
    TN13 1YG Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector118823420001
    GOODRICH, Michael John
    37 Eglantine Road
    SW18 2DE London
    Amministratore
    37 Eglantine Road
    SW18 2DE London
    EnglandBritishMarketing Consultant41860850001
    HORROCKS, Mark Ian
    18 Three Kings Yard
    W1K 4JT London
    Amministratore
    18 Three Kings Yard
    W1K 4JT London
    EnglandBritishDirector5412300001
    JACOBSON, Ronald Terry
    Abbotswood The Pastures
    N20 8AN London
    Amministratore
    Abbotswood The Pastures
    N20 8AN London
    United KingdomBritishStockbroker46756400001
    KILBRIDE, Ian William Sefton
    Oakwood 7 Oakhurst Avenue
    Hout Bay
    7806 Cape Town
    Western Cape
    South Africa
    Amministratore
    Oakwood 7 Oakhurst Avenue
    Hout Bay
    7806 Cape Town
    Western Cape
    South Africa
    BritishDirector75544810001
    LEVENE, Nicholas David Andrew
    The Briars
    Barnet Road
    EN5 3JZ Arkley
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Briars
    Barnet Road
    EN5 3JZ Arkley
    Hertfordshire
    BritishDirector58316700003
    LORENZ, Robert Roman
    3561 Tolland Road
    Shaker Heights
    Ohio
    Usa
    Amministratore
    3561 Tolland Road
    Shaker Heights
    Ohio
    Usa
    AmericanSurgeon119520250001
    OZMEN, Tamer
    Flat 6
    27-29 Britten Street
    SW3 3UD London
    Amministratore
    Flat 6
    27-29 Britten Street
    SW3 3UD London
    AmericanDirector93689370001
    REVELL-SMITH, Peter Anning
    78 Palace Gardens Terrace
    W8 4RS London
    Amministratore
    78 Palace Gardens Terrace
    W8 4RS London
    BritishInvestment Banker1602410001
    ROSS, Lionel Jack
    15 Valencia Road
    HA7 4JL Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    15 Valencia Road
    HA7 4JL Stanmore
    Middlesex
    BritishDirector1338810002
    SAKLATVALA, Theresa, Doctor
    Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    Amministratore
    Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    BritishDirector117894860001
    STANLEY, Paul Robert
    7 Northolm
    HA8 9RL Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    7 Northolm
    HA8 9RL Edgware
    Middlesex
    BritishDirector58251370002
    STIMPSON, Andrew David
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    Amministratore
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    EnglandBritishDirector99393670001
    STUTTAFORD, William Royden, Sir
    Moulshams Manor
    Great Wigborough
    CO5 7RL Colchester
    Essex
    Amministratore
    Moulshams Manor
    Great Wigborough
    CO5 7RL Colchester
    Essex
    BritishInvestment Manager6071220001
    USSI, Gino
    18 Avenue Mansions
    Finchley Road
    NW3 7AX London
    Amministratore
    18 Avenue Mansions
    Finchley Road
    NW3 7AX London
    ItalianDirector50943380002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    TOUCH GROUP PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 nov 2011
    Consegnato il 10 nov 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, equipment. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pauline Isaacs
    Transazioni
    • 10 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 05 gen 2011
    Consegnato il 15 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 08 mag 2009
    Consegnato il 15 mag 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £126,195.00 plus a sum equivalent to value added tax thereon.
    Persone aventi diritto
    • Zurich Assurance LTD
    Transazioni
    • 15 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Cash collateral account charge
    Creato il 23 mar 2004
    Consegnato il 25 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and touch (nw) limited (the obligors) and each of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in the account held by the company with the lender designated "manager obligation account for touch (nw) limited" with account no. 06023956 and the deposit being the amount from time to time standing to the credit of the account and all rights accruing in respect of the account.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 ott 2001
    Consegnato il 10 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from the borrower and each other obligor to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation from time to time granted or otherwise made available pursuant thereto or on any other account whatsoever together with all expenses and any interest charged under the terms of the debenture (all terms as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 feb 2001
    Consegnato il 13 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and obligations due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date
    Brevi particolari
    The rent deposit of £208,000.
    Persone aventi diritto
    • Futurestep (UK) Limited
    Transazioni
    • 13 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creato il 10 giu 1998
    Consegnato il 19 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the three leases of even date herewtih
    Brevi particolari
    £117,355.47.
    Persone aventi diritto
    • Classic Fm PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TOUCH GROUP PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 ago 2012Inizio della liquidazione
    05 gen 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Praticante
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0