ARGYLL HOLDINGS LIMITED

ARGYLL HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARGYLL HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03407554
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARGYLL HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova ARGYLL HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Jupiter House The Drive
    Warley Hill Business Park
    CM13 3BE Brentwood
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARGYLL HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARGENT GROUP EUROPE LIMITED28 ago 199728 ago 1997
    ESTEEMPRESS LIMITED23 lug 199723 lug 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARGYLL HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ARGYLL HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 giu 2012

    9 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Butts Green Road Hornchurch Essex RM11 2JX in data 14 mar 2012

    1 pagineAD01

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:secretary of state's release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Indirizzo della sede legale modificato da Level 5 9 Hatton Street London NW8 8PL in data 27 lug 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 giu 2011

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 24 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 lug 2010

    Stato del capitale al 28 lug 2010

    • Capitale: GBP 5,122.01
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew John Barnes il 20 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John Gray il 20 lug 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    legacy

    10 pagineMG01

    Risoluzioni

    Resolutions
    43 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Cessazione della carica di Andrew Hunter come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ARGYLL HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARNES, Andrew John
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    Amministratore
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    EnglandBritishChartered Accountant79031400002
    GRAY, David John
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    Amministratore
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director105745700001
    BARNES, Andrew John
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    Segretario
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    BritishFinance Director79031400002
    MORGAN, Peter Frederick
    The Oaks
    Spring Lane
    MK44 1AT Yelden
    Bedfordshire
    Segretario
    The Oaks
    Spring Lane
    MK44 1AT Yelden
    Bedfordshire
    BritishCompany Secretary1491120001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    HUNTER, Andrew Pennington Havard
    Ashlea House
    Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ashlea House
    Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Executive54239750004
    JOHNSON, Benjamin Clark
    3 Burnfoot Avenue
    SW6 5EB London
    Amministratore
    3 Burnfoot Avenue
    SW6 5EB London
    BritishFinancier108019120002
    JOY, Andrew Neville
    Marelands
    GU10 5JB Bentley
    Hampshire
    Amministratore
    Marelands
    GU10 5JB Bentley
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director44663290001
    KENISTON-COOPER, Graham James
    17 Ovington Square
    SW3 1LH London
    Amministratore
    17 Ovington Square
    SW3 1LH London
    EnglandBritishVenture Capitalist73698890002
    MCALPINE, Stuart Anderson
    14 Grange Road
    Barnes
    SW13 9RE London
    Amministratore
    14 Grange Road
    Barnes
    SW13 9RE London
    BritishInvestment Director97932330001
    MUNTON, Richard James
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    BritishInvestment Director11882410003
    MUSK, Michael John
    Great Batchelors
    Sissinghurst Road
    TN27 8EX Biddenden
    Kent
    Amministratore
    Great Batchelors
    Sissinghurst Road
    TN27 8EX Biddenden
    Kent
    United KingdomBritishDirector127656990001
    SCLATER, John Richard
    Sutton Hall
    Barcombe
    BN8 5EB Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    Sutton Hall
    Barcombe
    BN8 5EB Lewes
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director58987670002
    WOOD, Marcus James
    Eden House
    Eden Road
    TN1 1TS Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Eden House
    Eden Road
    TN1 1TS Tunbridge Wells
    Kent
    BritishAssistant Director63093770002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ARGYLL HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission
    Creato il 05 mar 2010
    Consegnato il 15 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 march 2007 and
    Creato il 20 feb 2008
    Consegnato il 12 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission
    Creato il 09 nov 2007
    Consegnato il 27 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the further company or by any one of the existing companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28TH march 2007 and
    Creato il 17 set 2007
    Consegnato il 25 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 28 mar 2007
    Consegnato il 05 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from or by any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 apr 2006
    Consegnato il 26 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 ott 2002
    Consegnato il 11 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 set 1997
    Consegnato il 06 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the finance documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ARGYLL HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 giu 2011Inizio della liquidazione
    24 gen 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas H O'Reilly
    43/45 Butts Green Road
    RM11 2JX Hornchurch
    Essex
    Praticante
    43/45 Butts Green Road
    RM11 2JX Hornchurch
    Essex
    Jonathan Mark Birch
    43/45 Butts Green Road
    RM11 2JX Hornchurch
    Essex
    Praticante
    43/45 Butts Green Road
    RM11 2JX Hornchurch
    Essex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0