&CO THE CULTURAL MARKETING HOUSE
Panoramica
| Nome della società | &CO THE CULTURAL MARKETING HOUSE |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited' |
| Numero di società | 03407918 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di &CO THE CULTURAL MARKETING HOUSE?
- Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova &CO THE CULTURAL MARKETING HOUSE?
| Indirizzo della sede legale | Studio 23/24 46 The Calls LS2 7EY Leeds |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di &CO THE CULTURAL MARKETING HOUSE?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| AUDIENCES YORKSHIRE | 31 gen 2002 | 31 gen 2002 |
| WEST YORKSHIRE ARTS MARKETING | 18 lug 1997 | 18 lug 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di &CO THE CULTURAL MARKETING HOUSE?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per &CO THE CULTURAL MARKETING HOUSE?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 lug 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2011 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Madani Younis come amministratore in data 28 mag 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alison Elizabeth Edbury come segretario in data 27 apr 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Judith Hartley come amministratore in data 02 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 lug 2011, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 11 pagine | AR01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2011 al 30 set 2011 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2010 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Judith Hartley come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 lug 2010, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 10 pagine | AR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Studio 23-24 Leeds Design Innovation Centre 46 the Calls, Leeds West Yorkshire LS2 7EY in data 16 set 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sheena Wrigley come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Clive Sydney Lawrence il 18 lug 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Madani Younis il 18 lug 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Helen Margaret Dobson il 18 lug 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 33 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Nomina di Ms Abbigail Wright come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Skipper come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2009 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di &CO THE CULTURAL MARKETING HOUSE?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON-WALLACE, Murray James Stuart | Amministratore | 5 Ancaster Road West Park LS16 5HH Leeds West Yorkshire | England | British | 69623280002 | |||||
| BAILEY, Christopher Albert, Professor | Amministratore | 103 Harehills Avenue LS8 4HU Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 126441840001 | |||||
| BATES, Daniel | Amministratore | 11 Garnett Terrace LS24 9BB Tadcaster North Yorkshire | United Kingdom | British | 76273230002 | |||||
| DOBSON, Helen Margaret | Amministratore | 129a The Mount YO24 1DU York North Yorkshire | England | British | 67528140001 | |||||
| GIBSON, Robert Martin | Amministratore | 13 St James Road LS29 9PY Ilkley West Yorkshire | England | British | 59836610001 | |||||
| LAWRENCE, Clive Sydney | Amministratore | Albert Road BD18 4NR Shipley 3 West Yorkshire United Kingdom | England | British | 61453120002 | |||||
| WRIGHT, Abbigail | Amministratore | St. Leonards Place YO1 7HD York York Theatre Royal North Yorkshire United Kingdom | England | British | 148586900001 | |||||
| EDBURY, Alison Elizabeth | Segretario | 12 Bank Avenue Horsforth LS18 4QX Leeds West Yorkshire | British | 88525450002 | ||||||
| HARGREAVES, Susan Elizabeth | Segretario | 42 The Old Village Huntington YO32 9RB York North Yorkshire | British | 52323050005 | ||||||
| BHATTI, Veena | Amministratore | Flat 40 Merchants House 66 North Street LS2 7PN Leeds West Yorkshire | British | 110211580002 | ||||||
| BOTTELEY, John Hubert Gregory | Amministratore | West House 76 High Street, Luddenden HX2 6PP Halifax West Yorkshire | British | 76480050001 | ||||||
| CANDLER, George | Amministratore | 5 Ewood Cottages Midgley Road HX7 5QU Hebden Bridge West Yorkshire | British | 84529630001 | ||||||
| DOVE, Simon | Amministratore | 5 Providence Chapel Beestonley Lane HX4 9PN Stainland West Yorkshire | British | 53696380001 | ||||||
| DRAKE, Jonathan Charles | Amministratore | The White House 79 Leeds Road WF15 6JA Liversedge West Yorkshire | British | 66681870003 | ||||||
| EDBURY, Alison | Amministratore | 38 Hunger Hills Avenue Horsforth LS18 5JT Leeds | British | 88525450001 | ||||||
| GALVIN, Angela Bernadette, Dr | Amministratore | 36 Sale Hill S10 5BX Sheffield South Yorkshire | England | British,Irish | 83089830001 | |||||
| HARTLEY, Judith | Amministratore | 46 The Calls LS2 7EY Leeds Studio 23/24 | England | British | 57167590001 | |||||
| KAKAR, Shahaa | Amministratore | 69 Easterly Crescent LS8 2SG Leeds West Yorkshire | British | 95440070002 | ||||||
| KESTON, Ludo | Amministratore | 268 High Street LS23 6AJ Boston Spa West Yorkshire | British | 102770030001 | ||||||
| LIDINGTON, Anthony James | Amministratore | 8 Ashdowne Place BD8 8AL Bradford West Yorkshire | British | 93814400001 | ||||||
| LUKIES, Christine Melanie | Amministratore | St Bernards Cottage Holcombe Village Holcombe EX7 0JT Dawlish Devon | United Kingdom | British | 59685940002 | |||||
| LUMB, Adam Thomas | Amministratore | 93 Wilkinson Street S10 2GJ Sheffield South Yorkshire | British | 102956050002 | ||||||
| MANTLE, Richard John | Amministratore | Cleaveland House Barrowby Lane Kirkby Overblow HG3 1HQ Harrogate | United Kingdom | British | 41844560003 | |||||
| MATHEWMAN, Su | Amministratore | 238 Beckfield Lane YO26 5QS York North Yorkshire | British | 118883310001 | ||||||
| MAWER, Kathryn Sarah | Amministratore | 18 Tillotson Street Silsden BD20 9LJ Keighley West Yorkshire | British | 102560110001 | ||||||
| MORRIS, Anita Helen | Amministratore | 50 Ash Grove LS29 8EP Ilkley West Yorkshire | British | 67172470001 | ||||||
| MORRIS, Anita Helen | Amministratore | 50 Ash Grove LS29 8EP Ilkley West Yorkshire | British | 67172470001 | ||||||
| O'BRIEN, Tamsin | Amministratore | 8 Lidgett Park Avenue LS8 1EN Leeds West Yorkshire | British | 106589690001 | ||||||
| PEARSON, Helen Claire | Amministratore | 132 Whingate LS12 3QU Leeds | British | 48217080001 | ||||||
| RASHID, Mehboob Ali | Amministratore | 34 Wetherby Road Oakwood LS8 2QG Leeds West Yorkshire | British | 80993290001 | ||||||
| ROBERTS, Philip Nathan | Amministratore | 22 M3 Building 91 Liverpool Road M3 4JN Manchester Lancashire | British | 118726240001 | ||||||
| ROMER, Marcus | Amministratore | 42 The Old Village Huntington YO32 9RB York North Yorkshire | United Kingdom | British | 62044490002 | |||||
| SAXON, Winifred Margaret | Amministratore | 3 Crispin Cottages Bakers Lane NN6 9QL Walgrave Northamptonshire | England | British | 156258980001 | |||||
| SKIPPER, Mark David | Amministratore | Hi-Lo Tivy Dale S75 4EH Cawthorne | England | British | 43591100003 | |||||
| SLATTERY, Claire | Amministratore | 1 Potternewton Lane Chapel Allerton LS7 3LW Leeds | England | British | 58558510002 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0