REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED

REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03410223
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Central House
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    REDSTONE MANAGED SOLUTIONS LIMITED07 nov 200707 nov 2007
    TOLERANT SYSTEMS LTD28 lug 199728 lug 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 09 dic 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account be cancelled 18/11/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Dean Anthony Barber come amministratore in data 03 apr 2020

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Dean Anthony Barber il 02 set 2019

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Dean Anthony Barber come amministratore in data 02 set 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019

    7 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Brotherton come segretario in data 03 set 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Harneet Jagpal come segretario in data 03 set 2018

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 lug 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Redcentric Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 27 mar 2018

    2 paginePSC09

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Fraser St John Fisher come amministratore in data 20 ott 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Peter James Brotherton come amministratore in data 28 nov 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Peter Brotherton come segretario in data 28 nov 2016

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAGPAL, Harneet
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Segretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    250197100001
    BROTHERTON, Peter James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Amministratore
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish116701310002
    BROTHERTON, Peter
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Segretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    222049800001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Segretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    210014220001
    CROFT, Estelle Louise
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Segretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    195008140001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Segretario
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    162493770001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    HWUVEL, Christopher Edward Francis Van Den
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Segretario
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British114731960001
    MYHILL, Paul Harvey
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Segretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    175307710001
    O'RORKE, Nicholas
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    Segretario
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    149400410001
    STIGWOOD, Roland Francis Wayne
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    Segretario
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    British46778900001
    TUNSTALL, Nicholas Paul
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    Segretario
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    British57548240002
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish82233550001
    BARBER, Dean Anthony
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Amministratore
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish230739040001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish163698620001
    FISHER, Fraser St John
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Amministratore
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish201664700001
    HALLETT, Peter John
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    Amministratore
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    United KingdomBritish20621770002
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Amministratore
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish20621770002
    PERKS, Timothy Howard
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish100207880001
    STIGWOOD, Roland Francis Wayne
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    Amministratore
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    British46778900001
    TUNSTALL, Lynn
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    Amministratore
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    EnglandBritish53939130002
    TUNSTALL, Nicholas Paul
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    Amministratore
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    United KingdomBritish57548240002
    WEAVER, Anthony Charles
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish153397180001
    YAPP, Stephen
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    Amministratore
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    EnglandBritish42686850001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Redcentric Holdings Limited
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006, United Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House, United Kingdom
    Numero di registrazione08399756
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    06 lug 201606 lug 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 apr 2015
    Consegnato il 08 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    Lease over first and second floor, griffin house, ludgate hill, birmingham.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 08 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 ott 2016Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 05 dic 2013
    Consegnato il 12 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 apr 2013
    Consegnato il 11 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group debenture
    Creato il 21 giu 2012
    Consegnato il 29 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 apr 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 11 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 lug 2004
    Consegnato il 05 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all specified debts and other debts. By way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cattles Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 03 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2000
    Consegnato il 03 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 15 dic 1998
    Consegnato il 19 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0