DIRECT AUTO FINANCE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DIRECT AUTO FINANCE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03412137 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | No. 1 Godwin Street BD1 2SU Bradford West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 7 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 4 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 7 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 13 lug 2021
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Neeraj Kapur come amministratore in data 01 apr 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon George Thomas come amministratore in data 31 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Charles Fisher come amministratore in data 03 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Simon George Thomas come amministratore in data 03 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2018 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David George Whincup come segretario in data 16 lug 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
legacy | pagine | ANNOTATION | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Paula Watts come segretario in data 31 mar 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Malcolm John Le May come amministratore in data 12 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Stuart Crook come amministratore in data 21 ago 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Paula Watts come segretario in data 12 mag 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Emma Gayle Versluys come segretario in data 12 mag 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHINCUP, David George | Segretario | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire | 251097020001 | |||||||
| KAPUR, Neeraj | Amministratore | No. 1 Godwin Street BD1 2SU Bradford Provident Financial Plc West Yorkshire United Kingdom | England | British | 268623050001 | |||||
| LE MAY, Malcolm John | Amministratore | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | England | British | 43422720003 | |||||
| MARSHALL SMITH, Rosamond Joy | Segretario | Colonnade Sunbridge Road BD1 2LQ Bradford West Yorkshire | British | 17986770001 | ||||||
| MEYRICK, Stephen John | Segretario | 16 Delanly Court Wimblehurst Road RG12 2DU Horsham West Sussex | British | 106205110001 | ||||||
| PRINCE, Joseph Michael | Segretario | Meadowside Piltdown TN22 3XD Uckfield East Sussex | British | 71867540001 | ||||||
| VERSLUYS, Emma Gayle | Segretario | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | British | 102724740003 | ||||||
| WATTS, Paula | Segretario | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire | 232277170001 | |||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| COOPER, Julian Edward Peregrine | Amministratore | 17b Sheridan Road Merton Park SW19 3HW London | United Kingdom | British | 91049680001 | |||||
| CROOK, Peter Stuart | Amministratore | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 109187730001 | |||||
| DUNKLEY, Paul John | Amministratore | The Barn House 8-10 North Street NN6 0DW Rothersthorpe Northants | British | 34398930001 | ||||||
| FARBRIDGE, Caroline Louise | Amministratore | 17 Holt Avenue Adel LS16 8DH Leeds West Yorkshire | British | 77093570001 | ||||||
| FARBRIDGE, Caroline Louise | Amministratore | 17 Holt Avenue Adel LS16 8DH Leeds West Yorkshire | British | 77093570001 | ||||||
| FISHER, Andrew Charles | Amministratore | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 41331580002 | |||||
| GLEN, Robert John | Amministratore | 5 High Meadows Firth Lane Wilsden BD15 0HN Bradford West Yorkshire | England | United Kingdom | 87214920001 | |||||
| HARRISON, Richard | Amministratore | 97 Orchard Grove Chalfont St Peter SL9 9ET Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 100892740002 | ||||||
| JOHNSTONE, Christopher Charles | Amministratore | Pine Lodge Castle Lane Ripponden HX6 4JZ Sowerby Bridge West Yorkshire | British | 53747580002 | ||||||
| LINDSEY, Ian Walter | Amministratore | 3 Kinderscout HP3 8HW Leverstock Green Hertfordshire | United Kingdom | British | 85980860001 | |||||
| MACLEOD, Gregory Ian | Amministratore | Murrayfield 13 Windsor Road SL9 7NB Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | Australian | 60518160005 | |||||
| MARSHALL SMITH, Rosamond Joy | Amministratore | Colonnade Sunbridge Road BD1 2LQ Bradford West Yorkshire | British | 17986770001 | ||||||
| MEYRICK, Stephen John | Amministratore | 16 Delanly Court Wimblehurst Road RG12 2DU Horsham West Sussex | British | 106205110001 | ||||||
| MEYRICK, Stephen John | Amministratore | 16 Delanly Court Wimblehurst Road RG12 2DU Horsham West Sussex | British | 106205110001 | ||||||
| NEWBY, Anthony Charles | Amministratore | Millhouse Church Road, Woolton L25 6DA Liverpool | British | 54172180002 | ||||||
| NEWBY, Anthony | Amministratore | 51 Wheatcroft Road Allerton L18 9UF Liverpool | British | 54172180001 | ||||||
| NEWBY, Leonard John | Amministratore | Scheveningen Huis Ashdown Road RH18 5BN Forest Row East Sussex | British | 55084420001 | ||||||
| NEWBY, Leonard John | Amministratore | Scheveningen Huis Ashdown Road RH18 5BN Forest Row East Sussex | British | 55084420001 | ||||||
| PARSONAGE, Robert David | Amministratore | Homeleigh 10 Chart Way RH2 0NZ Reigate Surrey | British | 108363060001 | ||||||
| PLOWMAN, Stephen Russell | Amministratore | Drummers Yard Sproutes Lane, Coolham RH13 8QH Horsham West Sussex | England | British | 76672190002 | |||||
| PLOWMAN, Stephen Russell | Amministratore | Drummers Yard Sproutes Lane, Coolham RH13 8QH Horsham West Sussex | England | British | 76672190002 | |||||
| PRINCE, Joseph Michael | Amministratore | Keffolds 44 Tongdean Avenue BN3 6TN Hove East Sussex | British | 71867540003 | ||||||
| SHAW, Simon Andrew | Amministratore | Horrocks Close BD20 8HQ Lothersdale North Yorkshire | Uk | British | 87062650001 | |||||
| THOMAS, Simon George | Amministratore | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire | England | British | 253188120001 | |||||
| THORNTON, John Rolfe | Amministratore | Kirk Lea Main Street HG5 9LD Staveley North Yorkshire | United Kingdom | British | 147555560001 | |||||
| WEBSTER, James Maxwell | Amministratore | 28d Cruden Street N1 8NH London | United Kingdom | British | 97036540001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provident Financial Plc | 06 apr 2016 | Godwin Street BD1 2SU Bradford No 1 Godwin Street England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
DIRECT AUTO FINANCE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creato il 26 lug 1999 Consegnato il 30 lug 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and each other company to the chargee on behalf of itself and the banks from time to time parties to the facility agreement under or pursuant to the secured documents (as defined) and all monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents and by any other present or future subsidiary of the parent or of any company and on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 11 feb 1999 Consegnato il 19 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a leased dated 11 february 1999 | |
Brevi particolari The initial deposit £27,500. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 16 dic 1997 Consegnato il 30 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents (as defined) and all monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents and by any other present or future subsidiary of the parent or of any company | |
Brevi particolari K/A unit 2 monckton road industrial estate denby dale road, wakefield t/no: WYK592491 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 12 nov 1997 Consegnato il 14 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Brevi particolari £48,468.75 and all interest credited to the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
DIRECT AUTO FINANCE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0