COTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES LTD

COTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03412310
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES LTD?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova COTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES LTD?

    Indirizzo della sede legale
    10 Priestley Road
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COTSWOLD WELDING SUPPLIES LIMITED11 mar 199811 mar 1998
    BOC NO.16 LIMITED31 lug 199731 lug 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di COTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per COTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Jeffery Bridger come amministratore in data 30 giu 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stuart Hudson come amministratore in data 30 giu 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Julian Michael Bland come amministratore in data 23 giu 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Graham Gill come amministratore in data 23 giu 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Jeffery Bridger il 22 giu 2016

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 mar 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 26 gen 2016

    21 pagineRP04

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 feb 2016

    Stato del capitale al 09 feb 2016

    • Capitale: GBP 250,001
    SH01
    Note
    DataNota
    04 mar 2016Clarification A second filed AR01 was registered on 04/03/2016

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    10 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Stuart Hudson il 14 mag 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 gen 2015

    Stato del capitale al 29 gen 2015

    • Capitale: GBP 250,001
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 10 Priestley Road Surrey Research Park Guildford Surrey GU2 7XY

    1 pagineAD04

    Indirizzo della sede legale modificato da Redfield Road Lenton Nottinghamshire NG7 2UJ a 10 Priestley Road Surrey Research Park Guildford Surrey GU2 7XY in data 31 ott 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 feb 2014

    Stato del capitale al 12 feb 2014

    • Capitale: GBP 250,001
    SH01

    Cessazione della carica di Claire Tuhme come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Claire Tuhme il 24 ott 2013

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di COTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KELLY, Susan Kathleen
    10 Priestley Road, The Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    Segretario
    10 Priestley Road, The Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    British71087960003
    BLAND, Julian Michael
    Midland Court, 2 Midland Way
    S43 4XA Barlborough Links
    The Linde Group
    England
    Amministratore
    Midland Court, 2 Midland Way
    S43 4XA Barlborough Links
    The Linde Group
    England
    EnglandBritish209449220001
    GILL, Graham
    10 Priestley Road, Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    England
    Amministratore
    10 Priestley Road, Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    England
    EnglandBritish66762510004
    GODLEY, Russell Christopher
    Leengate Welding Group Ltd
    Redfield Road, Lenton Lane Industrial Estate
    NG7 2UJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Leengate Welding Group Ltd
    Redfield Road, Lenton Lane Industrial Estate
    NG7 2UJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British70689790002
    HUNT, Carol Anne
    4 Alloway Close
    St Johns
    GU21 3HY Woking
    Surrey
    Segretario
    4 Alloway Close
    St Johns
    GU21 3HY Woking
    Surrey
    British40992870001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Segretario
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    British67168210001
    BAKER, Ian Kenneth Hood
    33 Atfield Grove
    GU20 6DP Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    33 Atfield Grove
    GU20 6DP Windlesham
    Surrey
    British3994580001
    BRIDGER, Andrew Jeffery
    10 Priestley Road, The Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group The Priestley Centre
    Surrey
    England
    Amministratore
    10 Priestley Road, The Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group The Priestley Centre
    Surrey
    England
    EnglandBritish163986520003
    CHAPMAN, Paul Jonathan
    Leengate Welding Group Ltd
    Redfield Road Lenton
    NG7 2UJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Leengate Welding Group Ltd
    Redfield Road Lenton
    NG7 2UJ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish61864480006
    FORD, James Alexander
    2 Parkside Place
    East Horsley
    KT24 5BZ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    2 Parkside Place
    East Horsley
    KT24 5BZ Leatherhead
    Surrey
    British38771470001
    GODLEY, Russell Christopher
    Leengate Welding Group Ltd
    Redfield Road, Lenton Lane Industrial Estate
    NG7 2UJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Leengate Welding Group Ltd
    Redfield Road, Lenton Lane Industrial Estate
    NG7 2UJ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish70689790002
    HADEN, Colin Dale
    17 Azalea Avenue
    GU35 0YD Lindford
    Hampshire
    Amministratore
    17 Azalea Avenue
    GU35 0YD Lindford
    Hampshire
    British61864640002
    HUDSON, Stuart
    10 Priestley Road, Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group The Priestley Centre
    Surrey
    England
    Amministratore
    10 Priestley Road, Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group The Priestley Centre
    Surrey
    England
    EnglandBritish164760810015
    HUGHES, David Michael
    75 Rydes Hill Road
    GU2 6SP Guildford
    Surrey
    Amministratore
    75 Rydes Hill Road
    GU2 6SP Guildford
    Surrey
    British57533810001
    JONES, Gwen Mai
    16 Cornwall Grove
    Chiswick
    W4 2LB London
    Amministratore
    16 Cornwall Grove
    Chiswick
    W4 2LB London
    United KingdomBritish57405710001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Amministratore
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    EnglandBritish67168210001
    TUHME, Claire
    Midland Court, 2 Midland Way
    S43 4XA Barlborough Links
    The Linde Group
    Amministratore
    Midland Court, 2 Midland Way
    S43 4XA Barlborough Links
    The Linde Group
    EnglandBritish168981720002
    WALKER, Raymond
    Leengate Welding Group Ltd
    Redfield Road, Lenton Lane Industrial Estate
    NG7 2UJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Leengate Welding Group Ltd
    Redfield Road, Lenton Lane Industrial Estate
    NG7 2UJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British104457030003

    COTSWOLD INDUSTRIAL & WELDING SUPPLIES LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over book debts
    Creato il 29 set 2000
    Consegnato il 13 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company but so that the company shall pay into the company's account with national westminster bank PLC all moneys which it may receive in respect of such debts and shall not without the prior consent in writing of national westminster bank PLC sell factor discount or otherwise charge or assign the same in favour of any other persons or purport to do so and the company shall if called upon so to do by national westminster bank PLC from time to time execute legal assignments of such book debts and other debts to national westminster bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0