THE DEVON DAIRY LIMITED

THE DEVON DAIRY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE DEVON DAIRY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03414586
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE DEVON DAIRY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tern Valley Business Park Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PENINSULA MILK PROCESSORS LIMITED05 ago 199705 ago 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Ronald Thornton come amministratore in data 30 ago 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Steven Paul Hodkinson come amministratore in data 30 ago 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Major Singh Rana come amministratore in data 30 ago 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Lee Greenbury come amministratore in data 18 dic 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Christopher Ronald Thornton come amministratore in data 13 nov 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Ronald Mcinnes come amministratore in data 01 ott 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Lee Greenbury come amministratore in data 12 giu 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ronald Klaas Otto Kers come amministratore in data 30 apr 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Maureen Agnes Burnside come segretario in data 31 mag 2017

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ago 2015

    Stato del capitale al 14 ago 2015

    • Capitale: GBP 366,039
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HODKINSON, Steven Paul
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Amministratore
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish217572630001
    RANA, Major Singh
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Amministratore
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish165428070001
    BURNSIDE, Maureen Agnes
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    Segretario
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    153975620001
    DAVIDSON, Allison Jane
    11 Teign Village Hennock
    Bovey Tracey
    TQ13 9QJ Newton Abbot
    Devon
    Segretario
    11 Teign Village Hennock
    Bovey Tracey
    TQ13 9QJ Newton Abbot
    Devon
    British84272680001
    KITTOW, Allison Jane
    11 Teign Village
    Hennock
    TQ13 9QJ Bovey Tracey
    Devon
    Segretario
    11 Teign Village
    Hennock
    TQ13 9QJ Bovey Tracey
    Devon
    British84082280001
    LAWRENCE, Geoffrey Owen
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    Segretario
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    British46842010001
    OPENSHAW, Sally Jane
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    Segretario
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    British54072560001
    REED, Lyndsay Anne
    19 Hawthorn Road
    Bishopsmead
    PL19 9DL Tavistock
    Devon
    Segretario
    19 Hawthorn Road
    Bishopsmead
    PL19 9DL Tavistock
    Devon
    British46842100001
    SWEENEY, Gerard
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    Segretario
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    British80242320001
    YOUNG, Karen Bridget
    3 Wild Orchard
    BA3 5XJ Faulkland
    Somerset
    Segretario
    3 Wild Orchard
    BA3 5XJ Faulkland
    Somerset
    British94953930001
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    Oceana House
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    Segretario
    Oceana House
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    59771390005
    BAKER, Peter Monty
    Three Oaks Gulworthy
    PL19 8AX Tavistock
    Devon
    Amministratore
    Three Oaks Gulworthy
    PL19 8AX Tavistock
    Devon
    British43634310001
    BENNETT, Alan
    Pengelly
    Hewas Water
    PL26 7JG St Austell
    Cornwall
    Amministratore
    Pengelly
    Hewas Water
    PL26 7JG St Austell
    Cornwall
    British71925150001
    BLADES, Laurence William
    Hurlditch Farm Lamerton
    PL19 8QA Tavistock
    Devon
    Amministratore
    Hurlditch Farm Lamerton
    PL19 8QA Tavistock
    Devon
    British52674990001
    BURROW, Richard
    Rill Farm
    East Hill
    EX11 1QH Ottery St. Mary
    Devon
    Amministratore
    Rill Farm
    East Hill
    EX11 1QH Ottery St. Mary
    Devon
    British71924930001
    DE BOER, Athe
    Lower Woodley
    PL30 5JN Bodmin
    Cornwall
    Amministratore
    Lower Woodley
    PL30 5JN Bodmin
    Cornwall
    Dutch43634210001
    GREENBURY, Lee
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Amministratore
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish61478920003
    KEANE, William Gerard
    33 Burnhead Road
    G43 2SU Glasgow
    Amministratore
    33 Burnhead Road
    G43 2SU Glasgow
    ScotlandBritish33614620001
    KERS, Ronald Klaas Otto
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    Amministratore
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    EnglandDutch165776800001
    KIDSON, Graham Leonard Patrick
    Teign Gorge House
    Sandy Park, Chagford
    TQ13 8JW Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Teign Gorge House
    Sandy Park, Chagford
    TQ13 8JW Newton Abbot
    Devon
    British63723090002
    LAMDEN, David
    Antony Pedigree Farms
    West Antony
    PL11 3AB Torpoint
    Cornwall
    Amministratore
    Antony Pedigree Farms
    West Antony
    PL11 3AB Torpoint
    Cornwall
    British54820180002
    LAWRENCE, Geoffrey Owen
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    Amministratore
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    British46842010001
    LOUD, Sandra Gladys
    Northdown
    Lewdown
    EX20 4EB Okehampton
    Devon
    Amministratore
    Northdown
    Lewdown
    EX20 4EB Okehampton
    Devon
    British54819870001
    MCINNES, Andrew Ronald
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    Amministratore
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    ScotlandBritish174315690001
    NICHOLLS, Barry John Leonard
    Stocks Farm House
    The Stocks, Seend
    SN12 6PL Melksham
    Wiltshire
    Amministratore
    Stocks Farm House
    The Stocks, Seend
    SN12 6PL Melksham
    Wiltshire
    EnglandBritish71018890006
    OPENSHAW, Nicholas Henry Folliott
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    Amministratore
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    United KingdomBritish44347590002
    OVENS, Jeremy
    Brendon Farm
    Halwill
    EX21 5UH Beaworthy
    Devon
    Amministratore
    Brendon Farm
    Halwill
    EX21 5UH Beaworthy
    Devon
    British65850270001
    PARISH, David Edmund
    Weir Mill Farm
    Willand
    EX15 2RE Cullompton
    Devon
    England
    Amministratore
    Weir Mill Farm
    Willand
    EX15 2RE Cullompton
    Devon
    England
    EnglandBritish34592070001
    POCOCK, Brian Walter
    Pennance Vean Farm
    Prosser Hill Gwithian
    TR27 5EB Hayle
    Cornwall
    Amministratore
    Pennance Vean Farm
    Prosser Hill Gwithian
    TR27 5EB Hayle
    Cornwall
    EnglandBritish84082420001
    RICHARDS, David Maldwyn
    Ash Grove
    BA5 2LX Wells
    4
    Somerset
    United Kingdom
    Amministratore
    Ash Grove
    BA5 2LX Wells
    4
    Somerset
    United Kingdom
    United KingdomBritish119384920003
    SWEENEY, Gerard
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    Amministratore
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    United KingdomBritish80242320001
    THORNTON, Christopher Ronald
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Amministratore
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish233720830001
    VENNING, Gerald William
    Lower Birch Farm
    Bere Alston
    PL20 7BY Yelverton
    Devon
    Amministratore
    Lower Birch Farm
    Bere Alston
    PL20 7BY Yelverton
    Devon
    British43634420001
    WILLIAMS, David Anthony James
    71a Long Ashton Road
    Long Ashton
    BS41 9HW Bristol
    Amministratore
    71a Long Ashton Road
    Long Ashton
    BS41 9HW Bristol
    EnglandBritish57267910003
    WISEMAN, Robert Tennant
    Auchterarder House
    PH3 1DZ Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    Auchterarder House
    PH3 1DZ Auchterarder
    Perthshire
    United KingdomBritish3813060003

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Müller Wiseman Dairies Limited
    Glasgow Road
    East Kilbride
    G74 4PA Glasgow
    159
    Scotland
    06 apr 2016
    Glasgow Road
    East Kilbride
    G74 4PA Glasgow
    159
    Scotland
    No
    Forma giuridicaCompany
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc146494
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    THE DEVON DAIRY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set off agreement
    Creato il 20 feb 2006
    Consegnato il 23 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 20 feb 2006
    Consegnato il 23 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All plant and machinery vehicles computers and other equipment being two vertical stainless steel raw milk intake tanks capacity: 11,000 litres, two vertical jacketed raw milk intake tanks capacity: 45,000 litres and three vertical jacketed storage tanks capacity: 45,000 litres for details of further chattels charged please refer to form 395, and all spare parts replacements modifications and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 feb 2006
    Consegnato il 23 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H properties k/a land being peninsula milk processing factory, hameldown road, okehampton t/n DN412666. Beardown road, exter road industrial estate, okehampton t/n DN480942 and l/h land being land at beardown road, exter road industrial estate, okehampton t/n DN480943, and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery, all moneys under contracts or policies of insurance relating to the property and the rents, profits, income fees and other sums payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 26 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 20 feb 2006
    Consegnato il 23 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 feb 2006
    Consegnato il 23 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 15 ott 2004
    Consegnato il 22 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of the chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property k/a peninsula milk processing factory,hameldown road,okehampton,t/no's DN412666 and DN480942(f/h) and DN480943(l/h). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerleenbank B.a as Security Trustee
    Transazioni
    • 22 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 set 2002
    Consegnato il 05 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 set 2002
    Consegnato il 02 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a peninsula milk processing factory, hameldown road, exeter, devon EX20 1UB t/no. DN412666 as continuing security for the payment of the mortgagee of all monies covenanted to be paid by the mortgagor and/or due to the mortgagee hereunder.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 set 2002
    Consegnato il 02 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 set 2002
    Consegnato il 02 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a peninsula milk processing facory, hameldown road, exeter, devon EX20 1UB. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 dic 1999
    Consegnato il 24 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement dated (as therein defined) or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed charge all specified debts being any book debts (purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement) the ownership of which fail to vest in the chargee for any reason together with the related rights pertaining to such book debts, all other debts being all amounts of indebtedness now or at any time owing to the company on any account whatsoever (together with the related rights) other than specified debts, floating charge such moneys which the company may receive in respect of the other debts.
    Persone aventi diritto
    • First National Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 24 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1999
    Consegnato il 02 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land situate at the exeter road industrial estate okehampton in the county of devon.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed & floating charge
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 10 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All debts and their related rights purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement which fail to vest absolutely and effectively in the security holder (for any reason) by way of floating charge all undertqaking and the property rights and assets of the company including stock in trade and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 10 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 mar 1998
    Consegnato il 27 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0