PREMIER INN MANCHESTER LIMITED
Panoramica
Nome della società | PREMIER INN MANCHESTER LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03416188 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
- Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GOLDEN TULIP MANCHESTER LIMITED | 28 lug 2003 | 28 lug 2003 |
EXTRAMINI LIMITED | 07 ago 1997 | 07 ago 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 02 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ago 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 02 mar 2017 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Edward Jones come amministratore in data 26 gen 2017 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Whitbread Secretaries Limited come segretario in data 26 gen 2017 | 3 pagine | AP04 | ||||||||||
Nomina di Daren Clive Lowry come amministratore in data 26 gen 2017 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Whitbread Directors 2 Limited come amministratore in data 26 gen 2017 | 3 pagine | AP02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Daren Clive Lowry come segretario in data 26 gen 2017 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Whitbread Directors 1 Limited come amministratore in data 26 gen 2017 | 3 pagine | AP02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bhavesh Mistry come amministratore in data 26 gen 2017 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 03 mar 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Charles Flaum come amministratore in data 30 set 2016 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Bhavesh Mistry il 12 dic 2014 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ago 2016 con aggiornamenti | 20 pagine | CS01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 26 feb 2015 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Simon Edward Jones come amministratore in data 14 ago 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di John Joseph Forrest come amministratore in data 06 lug 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Paul Charles Flaum come amministratore in data 05 feb 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Patrick Joseph Anthony Dempsey come amministratore in data 05 feb 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Stato del capitale al 24 feb 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITBREAD SECRETARIES LIMITED | Segretario | Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5XE Dunstable Whitbread Court Bedfordshire |
| 197001710001 | ||||||||||
LOWRY, Daren Clive | Amministratore | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 87044470002 | ||||||||
WHITBREAD DIRECTORS 1 LIMITED | Amministratore | Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5XE Dunstable Whitbread Court Bedfordshire |
| 164111250001 | ||||||||||
WHITBREAD DIRECTORS 2 LIMITED | Amministratore | Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5XE Dunstable Whitbread Court Bedfordshire |
| 197001670001 | ||||||||||
LOWRY, Daren Clive | Segretario | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | British | 87044470002 | ||||||||||
METCALF, Nicola Jane | Segretario | Flat 1 25 Kings Road HG1 5JY Harrogate North Yorkshire | British | Pa | 73359340001 | |||||||||
PRATT, Emma Kate | Segretario | 9 Saint Andrews Gate Kirkby Malzeard HG4 3SP Ripon North Yorkshire | British | Secretary | 80731880001 | |||||||||
WISH, Emma Louise | Segretario | The Hutts Grewelthorpe HG4 3DA Ripon North Yorkshire | British | Secretary | 50991790002 | |||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Amministratore | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | England | British | Managing Director | 100598030001 | ||||||||
DUKES, Paul | Amministratore | 508 Gilbert House Barbican EC2Y 8BD London | British | Leisure Consultant | 76027630002 | |||||||||
ELLIOT, Colin David | Amministratore | 54 Queens Grove NW8 6EN London | British | Company Director | 84492240002 | |||||||||
FLAUM, Paul Charles | Amministratore | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 97797290002 | ||||||||
FLAUM, Paul Charles | Amministratore | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 97797290002 | ||||||||
FORREST, John Joseph | Amministratore | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | England | British | Director | 204618050002 | ||||||||
GILL, David Alan | Amministratore | Spindles St Marys Road Bowdon WA14 2PH Altrincham Cheshire | England | British | Financial Director | 37437870002 | ||||||||
GREEN, John Louis | Amministratore | Hursley House The Warren, KT24 5RH East Horsley Surrey | England | British | Investment Management | 31444140002 | ||||||||
JONES, Simon Edward | Amministratore | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Managing Director Premier Inn Uk | 201568280001 | ||||||||
MISTRY, Bhavesh | Amministratore | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 139729660003 | ||||||||
PEARSON, Francis Nicholas Fraser, Sir | Amministratore | 9 Upper Addison Gardens W14 8AL London | United Kingdom | British | Leisure Consultant | 18912510001 | ||||||||
PELLINGTON, Andrew David | Amministratore | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 191886610001 | ||||||||
ROBERTS, Peter William Denby | Amministratore | The Hutts Hutts Lane, Grewelthorpe HG4 3DA Ripon | England | British | Leisure Consultant | 106538510001 | ||||||||
SCURRAH, Brian William | Amministratore | Wet Earth Green Pendlebury M27 8AL Manchester 11 | England | British | Construction Manager | 126400930002 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Inn Manchester Holdings Limited | 06 apr 2016 | Porz Avenue LU5 5XE Dunstable Whitbread Court United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
PREMIER INN MANCHESTER LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creato il 17 ott 2006 Consegnato il 01 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 31 mar 2006 Consegnato il 11 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Golden tulip hotel waters reach trafford park manchester t/no MAN44578. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of contracts by way of security | Creato il 10 apr 2002 Consegnato il 17 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The company assigns to the bank absolutely and with full title guarantee; all the rights, titles, benefits and interests of the company whatsoever present and future whether proprietary, contractual or otherwise; all book and other debts, revenues and claims both present and future;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 nov 1997 Consegnato il 20 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the property part title number GM610019 known as plot 1 wharfe side trafford park. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 ott 1997 Consegnato il 18 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0