GMAP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGMAP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03418634
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GMAP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GMAP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GMAP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FLAMMING ARROW LIMITED13 ago 199713 ago 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di GMAP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per GMAP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ago 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 ago 2016

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Jon Gordon il 22 lug 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ago 2015

    Stato del capitale al 26 ago 2015

    • Capitale: GBP 372
    SH01

    Nomina di Mr Robert Kenneth Campbell Munro come amministratore in data 01 mag 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Anne Richards come amministratore in data 30 apr 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert Kenneth Campbell Munro come segretario in data 01 mag 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Elizabeth Richards come segretario in data 30 apr 2015

    1 pagineTM02

    Secondo deposito di AP01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    5 pagineRP04
    Note
    DataNota
    31 mar 2015Clarification Second filing AP01 for Michael Jon Gordon.

    Nomina di Mr Michael Jon Gordon come amministratore in data 01 gen 2015

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Francis Mcandrew come amministratore in data 31 dic 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 set 2014

    Stato del capitale al 04 set 2014

    • Capitale: GBP 372
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 034186340004

    55 pagineMR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    8 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    15 pagineMR04

    Nomina di Mrs Elizabeth Richards come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GMAP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MUNRO, Robert Kenneth Campbell
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    One
    West Yorkshire
    Segretario
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    One
    West Yorkshire
    197731570001
    GORDON, Michael Jon
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    One
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    One
    West Yorkshire
    United KingdomBritish194337270002
    MUNRO, Robert Kenneth Campbell
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    One
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    One
    West Yorkshire
    EnglandBritish137091090001
    BIRKIN, Mark Henry
    Micklefield Grange Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Micklefield Grange Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    West Yorkshire
    British52031070001
    DAVIDSON, Gillian Mary
    Hainsworth Cottage
    Kildwick Grange
    BD20 9AD Kildwick
    West Yorkshire
    Segretario
    Hainsworth Cottage
    Kildwick Grange
    BD20 9AD Kildwick
    West Yorkshire
    British116222880001
    DAWSON, John William
    2 Overdale Grange
    BD23 6AG Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Overdale Grange
    BD23 6AG Skipton
    North Yorkshire
    British33836310003
    RICHARDS, Elizabeth
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    One
    West Yorkshire
    Segretario
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    One
    West Yorkshire
    181942430001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BIRKIN, Mark Henry
    Micklefield Grange Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Micklefield Grange Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    West Yorkshire
    British52031070001
    BODEN, Peter, Dr
    11 Beech Avenue
    Horsforth
    LS18 4PA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    11 Beech Avenue
    Horsforth
    LS18 4PA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish60165170001
    BODEN, Peter, Dr
    11 Beech Avenue
    Horsforth
    LS18 4PA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    11 Beech Avenue
    Horsforth
    LS18 4PA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish60165170001
    CLARKE, Martin Christopher, Professor
    The Manor House
    Leathley
    LS21 2JU Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Manor House
    Leathley
    LS21 2JU Otley
    West Yorkshire
    British29677580001
    CUTTER, David John
    Prospect House Farm
    High Bradley Lane, Bradley
    BD20 9EX Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Prospect House Farm
    High Bradley Lane, Bradley
    BD20 9EX Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritish70434220001
    DOBSON, John Kenneth
    Parkgate House
    Park Road, Guiseley
    LS20 8EN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Parkgate House
    Park Road, Guiseley
    LS20 8EN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish33267010002
    DULEY, Christopher Jozsef, Dr
    71 Jackson Avenue
    LS8 1NS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    71 Jackson Avenue
    LS8 1NS Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish62460040002
    FLETCHER, Janis Richardson
    4 The Stables
    Weeton Lane
    LS17 9LP Dunkeswick Harewood
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 The Stables
    Weeton Lane
    LS17 9LP Dunkeswick Harewood
    West Yorkshire
    British5868780002
    GOODFELLOW, John Graham
    3 White Hills Croft
    BD23 1LW Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    3 White Hills Croft
    BD23 1LW Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9666980007
    GREEN, Graham Andrew
    2 Ancaster View
    West Park
    LS16 5HR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Ancaster View
    West Park
    LS16 5HR Leeds
    West Yorkshire
    British26496790001
    GREEN, Michael John
    Crag Hill
    Hall Drive, Bramhope
    LS16 9JE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Crag Hill
    Hall Drive, Bramhope
    LS16 9JE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish3765320003
    MCANDREW, John Francis
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    One
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    One
    West Yorkshire
    EnglandBritish102419830002
    MCCORMICK, Ronald Joseph
    Ghaistrills
    Wharfeside Avenue Threshfield
    BD23 5BS Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Ghaistrills
    Wharfeside Avenue Threshfield
    BD23 5BS Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish26984930004
    MITCHELL, Andrew Darby
    74 Ramillies Road
    W4 1JA London
    Amministratore
    74 Ramillies Road
    W4 1JA London
    EnglandBritish4111810002
    RICHARDS, Elizabeth Anne
    23 Cavendish Avenue
    HG2 8HY Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    23 Cavendish Avenue
    HG2 8HY Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish61958280002
    STOCK, Thomas Joseph David
    Middle Farm Ratten Row
    Thruscross
    HG3 4BD Harrogate
    Amministratore
    Middle Farm Ratten Row
    Thruscross
    HG3 4BD Harrogate
    British2248170002
    TWIGG, Richard John
    Emsley House 1 Whiddon Croft
    Menston
    LS29 6QQ Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Emsley House 1 Whiddon Croft
    Menston
    LS29 6QQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish47283360005
    WILSON, Alan, Prof Sir
    Vice Chancellors Lodge
    Grosvenor Road
    LS6 2DZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Vice Chancellors Lodge
    Grosvenor Road
    LS6 2DZ Leeds
    West Yorkshire
    British67348480001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GMAP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Callcredit Marketing Limited
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    1
    England
    06 apr 2016
    Park Lane
    LS3 1EP Leeds
    1
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione02733070
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    GMAP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 09 apr 2014
    Consegnato il 16 apr 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Gmap - application number 2242471.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ge Corporate Finance Bank Sas, London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 16 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 26 ott 2012
    Consegnato il 02 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each present or future member of the group to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Corporate Finance Bank Sas
    Transazioni
    • 02 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group debenture
    Creato il 07 dic 2009
    Consegnato il 18 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 18 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 ott 1998
    Consegnato il 02 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0