GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD

GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03418652
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED14 ott 199714 ott 1997
    PRECIS (1570) LIMITED13 ago 199713 ago 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 nov 2021

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3AD England a Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ in data 10 dic 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Cessazione della carica di Vanessa Claire Balshaw come amministratore in data 04 ott 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3AD

    1 pagineAD04

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Vanessa Claire Balshaw il 20 apr 2020

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Fiona Jane Conway Blakemore come amministratore in data 12 dic 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Tania Inge Maria Cruickshank come segretario in data 13 set 2019

    2 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Vanessa Claire Balshaw come amministratore in data 01 lug 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Fiona Jane Conway Blakemore come amministratore in data 29 mar 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di George Edmund Richard Wood come amministratore in data 29 mar 2019

    1 pagineTM01

    Dettagli del segretario cambiati per Elizabeth Anne Woods il 22 ago 2017

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di John Spencer Morton come amministratore in data 30 nov 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Susan Crichton Kilgour come amministratore in data 30 nov 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    23 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRUICKSHANK, Tania Inge Maria
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Frp Advisory Trading Limited
    Segretario
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Frp Advisory Trading Limited
    262588700001
    WOODS, Elizabeth Anne
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Frp Advisory Trading Limited
    Segretario
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Frp Advisory Trading Limited
    185427240002
    KILGOUR, Susan Crichton
    2 Swan Lane
    EC4R 3AD London
    Riverbank House
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Swan Lane
    EC4R 3AD London
    Riverbank House
    United Kingdom
    EnglandBritish253138710001
    DANIELS, Lisa Jane
    Curzon Street
    W1J 5HB London
    One
    United Kingdom
    Segretario
    Curzon Street
    W1J 5HB London
    One
    United Kingdom
    158116950001
    GUEST, Robert Austin
    9 Chisholm Road
    TW10 6JH Richmond
    Surrey
    Segretario
    9 Chisholm Road
    TW10 6JH Richmond
    Surrey
    British44314180001
    GUEST, Robert Austin
    9 Chisholm Road
    TW10 6JH Richmond
    Surrey
    Segretario
    9 Chisholm Road
    TW10 6JH Richmond
    Surrey
    British44314180001
    MORTON, John Spencer
    Yew Tree Cottage
    7-8 Nettleden
    HP1 3DQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Yew Tree Cottage
    7-8 Nettleden
    HP1 3DQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British73601950001
    MORTON, John Spencer
    Yew Tree Cottage
    7-8 Nettleden
    HP1 3DQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Yew Tree Cottage
    7-8 Nettleden
    HP1 3DQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British73601950001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    10
    Segretario
    Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    10
    139030920001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Segretario
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Segretario
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    BALSHAW, Vanessa Claire
    2 Swan Lane
    EC4R 3AD London
    Riverbank House
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Swan Lane
    EC4R 3AD London
    Riverbank House
    United Kingdom
    United KingdomBritish260166390002
    BATAILLE, Alain
    47 Onslow Square
    SW7 3LR London
    Amministratore
    47 Onslow Square
    SW7 3LR London
    French79407390001
    BATES, Mikkel Gascoigne
    89 Boyne Road
    SE13 5AN London
    Amministratore
    89 Boyne Road
    SE13 5AN London
    EnglandBritish57415660001
    BLAKEMORE, Fiona Jane Conway
    2 Swan Lane
    EC4R 3AD London
    Riverbank House
    England
    Amministratore
    2 Swan Lane
    EC4R 3AD London
    Riverbank House
    England
    EnglandBritish120501860002
    BUFFET, Alex Jaques Guy
    37 Alexandra Court
    171/175 Queensgate
    SW7 5HQ London
    Amministratore
    37 Alexandra Court
    171/175 Queensgate
    SW7 5HQ London
    French37269510001
    FILBY, Simon Edward
    2 Lassa Road
    Eltham
    SE9 6PU London
    Amministratore
    2 Lassa Road
    Eltham
    SE9 6PU London
    British102816560001
    FUSCHILLO, Dino
    75 Noel Road
    N1 8HE London
    Amministratore
    75 Noel Road
    N1 8HE London
    United KingdomBritish56486620002
    GILMARTIN, Kevan Stuart
    Bremhill
    The Common
    HP4 2QF Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Bremhill
    The Common
    HP4 2QF Berkhamsted
    Hertfordshire
    British92667680001
    GREIG, Jonathan
    93 Clarendon Road
    W11 4JG London
    Amministratore
    93 Clarendon Road
    W11 4JG London
    EnglandBritish141566980001
    GUEST, Robert Austin
    9 Chisholm Road
    TW10 6JH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    9 Chisholm Road
    TW10 6JH Richmond
    Surrey
    UkBritish44314180001
    HILD, Stephane Jean
    47 Onslow Square
    SW7 3LR London
    Amministratore
    47 Onslow Square
    SW7 3LR London
    French37800820001
    HORLICK, Nicola Karina Christina
    30 Thurloe Square
    SW7 2SD London
    Amministratore
    30 Thurloe Square
    SW7 2SD London
    British53458480002
    IONS, John Stephen
    1 Framfield Road
    Highbury
    N5 1UU London
    Amministratore
    1 Framfield Road
    Highbury
    N5 1UU London
    United KingdomBritish42905720002
    JOBBINS, Alison
    14 Ingress Park Avenue
    DA9 9XJ Greenhithe
    Kent
    Amministratore
    14 Ingress Park Avenue
    DA9 9XJ Greenhithe
    Kent
    British120824590001
    LAGRANGE, Pierre Philippe Alexandre
    Curzon Street
    W1J 5HB London
    One
    United Kingdom
    Amministratore
    Curzon Street
    W1J 5HB London
    One
    United Kingdom
    EnglandBelgian161184130001
    LEEMAN, Matthew
    Old Orchard House
    Harpsden
    RG9 4AX Henley On Thames
    Amministratore
    Old Orchard House
    Harpsden
    RG9 4AX Henley On Thames
    British102816450001
    MCKELLICK, Christopher James
    51 Harrow Drive
    RM11 1NT Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    51 Harrow Drive
    RM11 1NT Hornchurch
    Essex
    British26238410001
    MORTON, John Spencer
    2 Swan Lane
    EC4R 3AD London
    Riverbank House
    England
    Amministratore
    2 Swan Lane
    EC4R 3AD London
    Riverbank House
    England
    United KingdomBritish73601950003
    MORTON, John Spencer
    Yew Tree Cottage
    7-8 Nettleden
    HP1 3DQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Yew Tree Cottage
    7-8 Nettleden
    HP1 3DQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish73601950001
    MURRAY, Malcolm Alexander
    46 Copsem Lane
    KT10 9HJ Esher
    Surrey
    Amministratore
    46 Copsem Lane
    KT10 9HJ Esher
    Surrey
    United KingdomBritish31353770002
    NUSSEIBEH, Saker Anwar, Dr
    21 Palace Gate
    W8 5LY London
    Amministratore
    21 Palace Gate
    W8 5LY London
    British91855640001
    O'SULLIVAN, Brian Christopher
    10 Hadley Road
    EN5 5HH Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    10 Hadley Road
    EN5 5HH Barnet
    Hertfordshire
    British47118120001
    PAGNI, Patrick Robert Marie
    24 Thurloe Square
    SW7 2SD London
    Amministratore
    24 Thurloe Square
    SW7 2SD London
    French33420570003

    Chi sono le persone con controllo significativo di GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    One Curzon Street
    W1J 5HB London
    One Curzon Street
    England
    06 apr 2016
    One Curzon Street
    W1J 5HB London
    One Curzon Street
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03349370
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 16 mar 2004
    Consegnato il 23 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equitable interest in the sum of £226,100.00 and any other sums paid into that account and any interest credited to that account being a specifically designated deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Banco Santander Central Hispano Sa
    Transazioni
    • 23 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 16 mar 2004
    Consegnato il 23 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £65,887.50 and any other sums paid into that account and any interest credited to that account being a specifically designated deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Banco Santander Central Hispano Sa
    Transazioni
    • 23 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 27 mar 2002
    Consegnato il 28 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company's equitable interest in: (a) £65,887.50 to be paid by the company to the landlord no later than 27 march 2003 and which the landlord is obliged under the deed to pay into the account; and (b) any other sums paid into that account by the company pursuant to the deed and any interest credited to that account which has not been released to the company.
    Persone aventi diritto
    • Banco Santander Central Hispano Sa
    Transazioni
    • 28 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 giu 2000
    Consegnato il 04 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the above deed
    Brevi particolari
    The equitable interest in the securitydeposit.
    Persone aventi diritto
    • Banco Santander Central Hispano Sa
    Transazioni
    • 04 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 mar 2023Data prevista di scioglimento
    24 nov 2021Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Martin Sheridan
    Kings Orchard 1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Avon
    Praticante
    Kings Orchard 1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Avon
    Gareth Rutt Morris
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Praticante
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0