GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD
Panoramica
| Nome della società | GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03418652 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Indirizzo della sede legale | Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED | 14 ott 1997 | 14 ott 1997 |
| PRECIS (1570) LIMITED | 13 ago 1997 | 13 ago 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3AD England a Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ in data 10 dic 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vanessa Claire Balshaw come amministratore in data 04 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3AD | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Vanessa Claire Balshaw il 20 apr 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Fiona Jane Conway Blakemore come amministratore in data 12 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Tania Inge Maria Cruickshank come segretario in data 13 set 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Vanessa Claire Balshaw come amministratore in data 01 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ms Fiona Jane Conway Blakemore come amministratore in data 29 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di George Edmund Richard Wood come amministratore in data 29 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Elizabeth Anne Woods il 22 ago 2017 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Spencer Morton come amministratore in data 30 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Susan Crichton Kilgour come amministratore in data 30 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUICKSHANK, Tania Inge Maria | Segretario | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol Frp Advisory Trading Limited | 262588700001 | |||||||||||
| WOODS, Elizabeth Anne | Segretario | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol Frp Advisory Trading Limited | 185427240002 | |||||||||||
| KILGOUR, Susan Crichton | Amministratore | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | England | British | 253138710001 | |||||||||
| DANIELS, Lisa Jane | Segretario | Curzon Street W1J 5HB London One United Kingdom | 158116950001 | |||||||||||
| GUEST, Robert Austin | Segretario | 9 Chisholm Road TW10 6JH Richmond Surrey | British | 44314180001 | ||||||||||
| GUEST, Robert Austin | Segretario | 9 Chisholm Road TW10 6JH Richmond Surrey | British | 44314180001 | ||||||||||
| MORTON, John Spencer | Segretario | Yew Tree Cottage 7-8 Nettleden HP1 3DQ Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 73601950001 | ||||||||||
| MORTON, John Spencer | Segretario | Yew Tree Cottage 7-8 Nettleden HP1 3DQ Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 73601950001 | ||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Upper Bank Street E14 5JJ London 10 | 139030920001 | |||||||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Segretario | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 2519400001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Segretario | 1st Floor 9 Cloak Lane EC4R 2RU London Pellipar House United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
| BALSHAW, Vanessa Claire | Amministratore | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | United Kingdom | British | 260166390002 | |||||||||
| BATAILLE, Alain | Amministratore | 47 Onslow Square SW7 3LR London | French | 79407390001 | ||||||||||
| BATES, Mikkel Gascoigne | Amministratore | 89 Boyne Road SE13 5AN London | England | British | 57415660001 | |||||||||
| BLAKEMORE, Fiona Jane Conway | Amministratore | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House England | England | British | 120501860002 | |||||||||
| BUFFET, Alex Jaques Guy | Amministratore | 37 Alexandra Court 171/175 Queensgate SW7 5HQ London | French | 37269510001 | ||||||||||
| FILBY, Simon Edward | Amministratore | 2 Lassa Road Eltham SE9 6PU London | British | 102816560001 | ||||||||||
| FUSCHILLO, Dino | Amministratore | 75 Noel Road N1 8HE London | United Kingdom | British | 56486620002 | |||||||||
| GILMARTIN, Kevan Stuart | Amministratore | Bremhill The Common HP4 2QF Berkhamsted Hertfordshire | British | 92667680001 | ||||||||||
| GREIG, Jonathan | Amministratore | 93 Clarendon Road W11 4JG London | England | British | 141566980001 | |||||||||
| GUEST, Robert Austin | Amministratore | 9 Chisholm Road TW10 6JH Richmond Surrey | Uk | British | 44314180001 | |||||||||
| HILD, Stephane Jean | Amministratore | 47 Onslow Square SW7 3LR London | French | 37800820001 | ||||||||||
| HORLICK, Nicola Karina Christina | Amministratore | 30 Thurloe Square SW7 2SD London | British | 53458480002 | ||||||||||
| IONS, John Stephen | Amministratore | 1 Framfield Road Highbury N5 1UU London | United Kingdom | British | 42905720002 | |||||||||
| JOBBINS, Alison | Amministratore | 14 Ingress Park Avenue DA9 9XJ Greenhithe Kent | British | 120824590001 | ||||||||||
| LAGRANGE, Pierre Philippe Alexandre | Amministratore | Curzon Street W1J 5HB London One United Kingdom | England | Belgian | 161184130001 | |||||||||
| LEEMAN, Matthew | Amministratore | Old Orchard House Harpsden RG9 4AX Henley On Thames | British | 102816450001 | ||||||||||
| MCKELLICK, Christopher James | Amministratore | 51 Harrow Drive RM11 1NT Hornchurch Essex | British | 26238410001 | ||||||||||
| MORTON, John Spencer | Amministratore | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House England | United Kingdom | British | 73601950003 | |||||||||
| MORTON, John Spencer | Amministratore | Yew Tree Cottage 7-8 Nettleden HP1 3DQ Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 73601950001 | |||||||||
| MURRAY, Malcolm Alexander | Amministratore | 46 Copsem Lane KT10 9HJ Esher Surrey | United Kingdom | British | 31353770002 | |||||||||
| NUSSEIBEH, Saker Anwar, Dr | Amministratore | 21 Palace Gate W8 5LY London | British | 91855640001 | ||||||||||
| O'SULLIVAN, Brian Christopher | Amministratore | 10 Hadley Road EN5 5HH Barnet Hertfordshire | British | 47118120001 | ||||||||||
| PAGNI, Patrick Robert Marie | Amministratore | 24 Thurloe Square SW7 2SD London | French | 33420570003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glg Partners Uk Group Ltd | 06 apr 2016 | One Curzon Street W1J 5HB London One Curzon Street England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 16 mar 2004 Consegnato il 23 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The equitable interest in the sum of £226,100.00 and any other sums paid into that account and any interest credited to that account being a specifically designated deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 16 mar 2004 Consegnato il 23 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The sum of £65,887.50 and any other sums paid into that account and any interest credited to that account being a specifically designated deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 27 mar 2002 Consegnato il 28 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company's equitable interest in: (a) £65,887.50 to be paid by the company to the landlord no later than 27 march 2003 and which the landlord is obliged under the deed to pay into the account; and (b) any other sums paid into that account by the company pursuant to the deed and any interest credited to that account which has not been released to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 30 giu 2000 Consegnato il 04 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the above deed | |
Brevi particolari The equitable interest in the securitydeposit. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0