PRESSAC (UK) LIMITED

PRESSAC (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRESSAC (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03420207
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRESSAC (UK) LIMITED?

    • (3220) /

    Dove si trova PRESSAC (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Glaisdale Drive West
    Bilborough Nottingham
    NG8 4GY Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PRESSAC (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRESSAC COMMUNICATIONS LIMITED04 giu 200704 giu 2007
    PRESSAC COMMUNICATIONS LIMITED07 ott 199707 ott 1997
    PRESSAC LIMITED02 ott 199702 ott 1997
    NOTTCOR 47 LIMITED15 ago 199715 ago 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRESSAC (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per PRESSAC (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    1 pagine652a
    A14EC98M

    legacy

    3 pagine363a
    X0X50ZQO

    legacy

    1 pagine288b
    ADX26ZPG

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    19 pagineAA
    AG3DZZLP

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    24 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    8 pagineMA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed pressac communications LIMITED\certificate issued on 06/06/07
    2 pagineCERTNM

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    22 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    18 pagineAA

    legacy

    7 pagine395

    legacy

    11 pagine395

    legacy

    7 pagine395

    legacy

    3 pagine395

    Chi sono gli amministratori di PRESSAC (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURBIDGE, Peter Leslie
    Elm Cottage Gonerby Court
    Gonerby Road
    NG31 8HT Grantham
    Amministratore
    Elm Cottage Gonerby Court
    Gonerby Road
    NG31 8HT Grantham
    United KingdomBritishDirector64511710005
    HOWELL, Colin Anthony
    Haytor
    Main Street
    NN6 8BU East Haddon
    Northampton
    Amministratore
    Haytor
    Main Street
    NN6 8BU East Haddon
    Northampton
    United KingdomBritishCompany Director31870080001
    BARKER, Anthony
    7 Mear Drive
    Borrowash
    DE72 3QW Derby
    Segretario
    7 Mear Drive
    Borrowash
    DE72 3QW Derby
    BritishAccountant83350930002
    BARKER, Anthony
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    Segretario
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    BritishCompany Director83350930001
    DAVID, Alastair Cameron
    Northumberland Road
    CV32 6HG Leamington Spa
    108
    Warwickshire
    United Kingdom
    Segretario
    Northumberland Road
    CV32 6HG Leamington Spa
    108
    Warwickshire
    United Kingdom
    British130261580001
    GATFORD, Kerry Louise
    18 Rectory Road
    West Bridgford
    NG2 6BG Nottingham
    Segretario
    18 Rectory Road
    West Bridgford
    NG2 6BG Nottingham
    BritishParalegal Assistant58359470002
    PROSSER, Michael Trevelyan
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    Segretario
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    BritishFinance Director69196950002
    AIKMAN, Elizabeth Jane
    4 Red Cedar Road
    MK43 8GL Bromham
    Bedfordshire
    Amministratore
    4 Red Cedar Road
    MK43 8GL Bromham
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director256777440001
    BARKER, Anthony
    7 Mear Drive
    Borrowash
    DE72 3QW Derby
    Amministratore
    7 Mear Drive
    Borrowash
    DE72 3QW Derby
    BritishAccountant83350930002
    BARKER, Anthony
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    Amministratore
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    BritishCompany Director83350930001
    BROWN, Julia Diane
    2 Wheathill Grove
    Littleover
    DE23 7XW Derby
    Amministratore
    2 Wheathill Grove
    Littleover
    DE23 7XW Derby
    BritishSolicitor62842870002
    GASKELL, Paul Gordon
    60 Copeland Drive
    Standish
    WN6 0XR Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    60 Copeland Drive
    Standish
    WN6 0XR Wigan
    Lancashire
    BritishDirector77954730005
    GATFORD, Kerry Louise
    18 Rectory Road
    West Bridgford
    NG2 6BG Nottingham
    Amministratore
    18 Rectory Road
    West Bridgford
    NG2 6BG Nottingham
    BritishParalegal Assistant58359470002
    GORDON, Harry Stuart
    Greylands Mereside Road
    Mere
    WA16 6QQ Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Greylands Mereside Road
    Mere
    WA16 6QQ Knutsford
    Cheshire
    BritishOperations Manager25073230002
    GRAY, Roger Charles
    3 Litton Close
    NG15 9EW Ravenshead
    Nottingham
    Amministratore
    3 Litton Close
    NG15 9EW Ravenshead
    Nottingham
    BritishCompany Director77954750001
    KING, Anthony Clive Garner
    Gowan Bank
    47 Broadway
    DE56 4BU Duffield
    Derbyshire
    Amministratore
    Gowan Bank
    47 Broadway
    DE56 4BU Duffield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director108853950001
    LEWIS, Huw Roderic
    26 Chattaway Drive
    Balsall Common
    CV7 7QH Coventry
    Warwickshire
    Amministratore
    26 Chattaway Drive
    Balsall Common
    CV7 7QH Coventry
    Warwickshire
    BritishAccountant13419660001
    NEWSOME, Adrian John
    4 Wingate Drive
    MK45 2XF Ampthill
    Bedfordshire
    Amministratore
    4 Wingate Drive
    MK45 2XF Ampthill
    Bedfordshire
    BritishCompany Director85846970001
    PROSSER, Michael Trevelyan
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    BritishFinance Director69196950002
    ROBERTS, Paul Philip
    Diamond House
    Odell Road Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    Amministratore
    Diamond House
    Odell Road Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    BritishCompany Director94196530001
    WALTER, Derek Edmund Piers
    Hazelewell Road
    Putney
    SW15 6GT London
    19
    Amministratore
    Hazelewell Road
    Putney
    SW15 6GT London
    19
    EnglandBritishCompany Director155090910001
    WHITE, Geoffrey Charles
    8 Rawlings Street
    SW3 2LS London
    Amministratore
    8 Rawlings Street
    SW3 2LS London
    BritishAccountant86433340001
    WHITTAKER, David
    106 Gray Run
    Huntsville
    Alabama 35824
    Usa
    Amministratore
    106 Gray Run
    Huntsville
    Alabama 35824
    Usa
    BritishCompany Director82130600001
    WOODWARK, Christopher John Stuart
    Holm Beech
    Wood End Close One Pin Lane
    SL2 3RF Farnham Common
    Bucks
    Amministratore
    Holm Beech
    Wood End Close One Pin Lane
    SL2 3RF Farnham Common
    Bucks
    EnglandBritishCompany Director29679520001

    PRESSAC (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 23 feb 2006
    Consegnato il 03 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h land and buildings on the south east side of glaisdale drive west bilborough nottingham nottinghamshire t/n NT209316. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 23 feb 2006
    Consegnato il 03 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a land and buildingson the south east side of glasidale driv. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 23 feb 2006
    Consegnato il 04 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgaged chattels,the benefit of any guarantee,warranty or other obligation in relation to the mortgaged chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 23 feb 2006
    Consegnato il 04 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 31 lug 2002
    Consegnato il 07 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from each chargor to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All estates or interests in any freehold or leasehold property with all buildings,fixtures,fittings,fixed plant and machinery thereon; the benefit of any covenants for title or any moneys paid thereunder; all shares in any member of the group and all stocks,debentures,bonds or other securities and investments,dividend,right,money or property accruing; all amounts standing to the credit of any account and all book/other debts,securities or guarantees; all other contracts and intellectual property; see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC,as Agent and Trustee for the Transaction Parties
    Transazioni
    • 07 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0