LFI1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLFI1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03420548
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LFI1 LIMITED?

    • Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LFI1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LFI1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEATHERHEAD FOOD INTERNATIONAL LIMITED12 ago 200212 ago 2002
    LFRA LIMITED07 dic 199907 dic 1999
    CITEGOOD LIMITED15 ago 199715 ago 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di LFI1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per LFI1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    23 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 set 2018

    18 pagineLIQ03

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 gen 2017

    2 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 set 2017

    17 pagineLIQ03

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 05 set 2016

    19 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 15 mar 2016

    15 pagine2.24B

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed leatherhead food international LIMITED\certificate issued on 10/12/15
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 22 ott 2015

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    12 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    47 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Randalls Road Leatherhead Surrey KT22 7RY a Allen House 1 Westmead Road Sutton Surrey SM1 4LA in data 29 set 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 04 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 set 2015

    Stato del capitale al 28 set 2015

    • Capitale: GBP 4,623,776
    SH01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Jonathan Nicholas Gordon-Smith come amministratore in data 26 set 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Nicholas Gordon-Smith come segretario in data 26 set 2014

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr James Ross Hiley come amministratore in data 26 set 2014

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di LFI1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HILEY, James
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    Segretario
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    191289160001
    CLARKE, Belinda Rosanna, Dr
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    Amministratore
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    United KingdomBritish166159650002
    HILEY, James Ross
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    Amministratore
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    EnglandBritish102442450002
    SAMUEL, Michael John, Mr.
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    Amministratore
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    EnglandBritish13896090003
    SPRIEGEL, Geoffrey Donald, Dr
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    Amministratore
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    United KingdomBritish28327940001
    CROSER, William James
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    Segretario
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    British58808760002
    GARDNER, Michael
    11 St Leonards Close
    OX9 5PQ Watlington
    Oxfordshire
    Segretario
    11 St Leonards Close
    OX9 5PQ Watlington
    Oxfordshire
    British16045160001
    GORDON-SMITH, Jonathan Nicholas
    169 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    Segretario
    169 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    British112761660002
    QUINN, Brian Gerald
    10 Rydens Park
    KT12 3DP Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    10 Rydens Park
    KT12 3DP Walton On Thames
    Surrey
    British37003910002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BECKETT, Peter Charles
    41 Russell Hill Road
    CR8 2LD Purley
    Surrey
    Amministratore
    41 Russell Hill Road
    CR8 2LD Purley
    Surrey
    United KingdomBritish20786120001
    BERRYMAN, Paul Marcel, Dr
    Pear Tree Cottage
    Cheriton
    SO24 OPW Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    Pear Tree Cottage
    Cheriton
    SO24 OPW Alresford
    Hampshire
    Great BritainBritish114447040001
    BEVINGTON, John David
    Bramble Hill
    Heath Way
    KT24 5ET East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Bramble Hill
    Heath Way
    KT24 5ET East Horsley
    Surrey
    British77280360001
    BOOTE, Amanda
    141 High Road
    KT14 7RJ Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    141 High Road
    KT14 7RJ Byfleet
    Surrey
    British113674480001
    CROSER, William James
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    British58808760002
    FORAGE, Alan James, Dr
    3 Berkley Road
    Knotty Green
    HP9 2AY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    3 Berkley Road
    Knotty Green
    HP9 2AY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British19925910001
    FRY, Ann
    Amethyst House
    Odiham Road
    RG27 8BU Winchfield
    Hampshire
    Amministratore
    Amethyst House
    Odiham Road
    RG27 8BU Winchfield
    Hampshire
    EnglandBritish73546060001
    GORDON SMITH, Jonathan
    169 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    169 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    Great BritainBritish112761660001
    GORDON-SMITH, Jonathan Nicholas
    169 Cavendish Meads
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    169 Cavendish Meads
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish112761660002
    HANLEY, Anthony Bryan, Dr
    4 Tudor Walk
    KT22 7HX Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    4 Tudor Walk
    KT22 7HX Leatherhead
    Surrey
    British99475600001
    HARGREAVES, Neil Graham, Dr
    6 The Paddock
    Curzon Park
    CH4 8AE Chester
    Cheshire
    Amministratore
    6 The Paddock
    Curzon Park
    CH4 8AE Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish113674240001
    HARRIS, Alan Anthony
    5 Eriswell Crescent
    KT12 5DS Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    5 Eriswell Crescent
    KT12 5DS Walton On Thames
    Surrey
    British45879630001
    HOWLING, David, Dr
    38 Taunton Road
    M33 5DN Sale
    Cheshire
    Amministratore
    38 Taunton Road
    M33 5DN Sale
    Cheshire
    British7194300001
    JANES, Mark Brough
    Randalls Road
    Leatherhead
    KT22 7RY Surrey
    Amministratore
    Randalls Road
    Leatherhead
    KT22 7RY Surrey
    United KingdomBritish53089340001
    KIERSTAN, Marek Piotr Jacek, Doctor
    149 High Street
    Sawston
    CB2 4HJ Cambridge
    Amministratore
    149 High Street
    Sawston
    CB2 4HJ Cambridge
    British38879800002
    PEACOCK, Brian David
    87 George Lane
    Notton
    WF4 2NQ Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    87 George Lane
    Notton
    WF4 2NQ Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish3314300001
    PENMAN, Alistair, Dr
    Trefenna
    Bubnell Lane
    DE45 1RL Baslow
    Derbyshire
    Amministratore
    Trefenna
    Bubnell Lane
    DE45 1RL Baslow
    Derbyshire
    United KingdomBritish100933740001
    PUGH, Richard Forrest, Doctor
    5 Warren Way
    AL6 0DQ Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Warren Way
    AL6 0DQ Welwyn
    Hertfordshire
    British47763170001
    QUINN, Brian Gerald
    10 Rydens Park
    KT12 3DP Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    10 Rydens Park
    KT12 3DP Walton On Thames
    Surrey
    British37003910002
    REEVES, Anthony Raymond
    2 Willincroft Cottages
    Pinvin
    WR10 2LB Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    2 Willincroft Cottages
    Pinvin
    WR10 2LB Pershore
    Worcestershire
    British67811450001
    ROLFE, Peter
    Greenfields
    Sandy Way, Maybury
    GU2 2BB Woking
    Surrey
    Amministratore
    Greenfields
    Sandy Way, Maybury
    GU2 2BB Woking
    Surrey
    British124178380001
    SHAPLEY, Giles Martin William
    133 Elmbridge Avenue
    Surbiton
    KT5 9HE Surrey
    Amministratore
    133 Elmbridge Avenue
    Surbiton
    KT5 9HE Surrey
    Other95621860001
    YOUNG, John Nigel
    7 The Moorings
    Bookham
    KT23 3QA Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    7 The Moorings
    Bookham
    KT23 3QA Leatherhead
    Surrey
    British70068810001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    LFI1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 mag 2007
    Consegnato il 08 giu 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the trustees of the leatherhead international pension scheme (the scheme) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings lying on the east side of randalls way leatherhead.
    Persone aventi diritto
    • Brian Gandy and Mike Marrs and the Law Debenture Pension Trust Corporation PLC in Theircapacity as Trustees of the Leatherhead International Pension Scheme
    Transazioni
    • 08 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 209 feb 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 309 feb 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 209 feb 2018Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 209 feb 2018Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 2
      • Numero di pratica 3
    Legal charge
    Creato il 13 feb 2007
    Consegnato il 14 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the trustees of the leatherhead international pension scheme under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings lying on the east side of randalls way, leatherhead. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Geoffrey Ford, Brian Gandy and Mike Marrs and the Law Debenture Pension Trust Corporation Plcas Trustees of the Scheme (The Trustees)
    Transazioni
    • 14 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 set 2006
    Consegnato il 09 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings lying on the east side of randalls way, leatherhead.
    Persone aventi diritto
    • Geoffrey Ford, Brian Gandy and Mike Marrs and the Law Debenture Pension Trust Corporation PLC International Pension Scheme
    • Geoffrey Ford, Brian Gandy and Mike Marrs and the Law Debenture Pension Trust Corporation Plcin Their Capacity as Trustees of the Leatherhead
    Transazioni
    • 09 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 2005
    Consegnato il 11 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a leatherhead foods international limited randalls road leatherhead.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)

    LFI1 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 set 2015Inizio dell'amministrazione
    05 set 2016Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    James E Patchett
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Praticante
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Martin Charles Armstrong
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Praticante
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter John Cambray Loveday
    2 Southwark Street
    SE1 1TQ London
    Ricevitore/gestore
    2 Southwark Street
    SE1 1TQ London
    Colin Richard Jennings
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Ricevitore/gestore
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    3Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter John Cambray Loveday
    2 Southwark Street
    SE1 1TQ London
    Ricevitore/gestore
    2 Southwark Street
    SE1 1TQ London
    Colin Richard Jennings
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Ricevitore/gestore
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    4
    DataTipo
    05 set 2016Inizio della liquidazione
    30 dic 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    James E Patchett
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Liquidatore proposto
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Martin Charles Armstrong
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Liquidatore proposto
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Martin Charles Armstrong
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Praticante
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    James E Patchett
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Praticante
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0