COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED

COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03422275
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    • Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Mary Street House
    Mary Street
    TA1 3NW Taunton
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 ott 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:resolution re: liquidators authority
    1 pagineLIQ MISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 giu 2017

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Whiteoaks Farm the Old Sidings Corsham Road Lacock Wiltshire SN15 2LZ a Mary Street House Mary Street Taunton TA1 3NW in data 21 giu 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 01 ott 2016

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di James David Sheppard come amministratore in data 19 giu 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James David Sheppard come segretario in data 19 giu 2017

    1 pagineTM02

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    7 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 034222750009 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 034222750010 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 034222750008 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 034222750011 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 03 ott 2015

    6 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 034222750011, creata il 18 apr 2016

    35 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 034222750010, creata il 18 apr 2016

    10 pagineMR01

    Nomina di Mr Adrian David Gott come amministratore in data 18 apr 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 set 2015

    Stato del capitale al 01 set 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 27 set 2014

    6 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 034222750009, creata il 30 mag 2015

    10 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOTT, Adrian David
    Nether Kellet
    LA6 1DZ Carnforth
    Addington Lodge
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Nether Kellet
    LA6 1DZ Carnforth
    Addington Lodge
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish111647120004
    HOWMAN, William Angia
    3 Orchard Way
    NR18 0NX Wymondham
    Norfolk
    Segretario
    3 Orchard Way
    NR18 0NX Wymondham
    Norfolk
    British46577370001
    REDMAN, Nicholas James
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    Segretario
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    British74444770001
    SHEPPARD, James David
    Whiteoaks Farm
    The Old Sidings Corsham Road
    SN15 2LZ Lacock
    Wiltshire
    Segretario
    Whiteoaks Farm
    The Old Sidings Corsham Road
    SN15 2LZ Lacock
    Wiltshire
    147723070001
    SWAFFIELD, Roger Leslie
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    Segretario
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    British104835460001
    SWAFFIELD, Roger Leslie
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    Segretario
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    British104835460001
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    BOWEN-THOMAS, Peter
    Willowdene
    Wades Way Trunch
    NR28 0PW North Walsham
    Norfolk
    Amministratore
    Willowdene
    Wades Way Trunch
    NR28 0PW North Walsham
    Norfolk
    British21384770001
    CANNOCK, Richard Jeffrey
    26 Rupert Road
    RG14 7EL Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    26 Rupert Road
    RG14 7EL Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish172177850002
    HOWMAN, William Angia
    3 Orchard Way
    NR18 0NX Wymondham
    Norfolk
    Amministratore
    3 Orchard Way
    NR18 0NX Wymondham
    Norfolk
    EnglandBritish46577370001
    KENT, Michael Richard John
    Horizon Poultry Farm
    Tremar
    PL14 6EA Liskeard
    Cornwall
    Amministratore
    Horizon Poultry Farm
    Tremar
    PL14 6EA Liskeard
    Cornwall
    British67069980001
    REDMAN, Nicholas James
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    Amministratore
    21 Pages Lane
    TN39 3RD Bexhill On Sea
    East Sussex
    British74444770001
    ROGERS, Nicholas Ian
    16 Rapson Road
    PL14 3NX Liskeard
    Cornwall
    Amministratore
    16 Rapson Road
    PL14 3NX Liskeard
    Cornwall
    British42807600003
    SHEPPARD, James David
    Gorse Cottage
    New Lydd Road, Camber
    TN31 7QS Rye
    East Sussex
    Amministratore
    Gorse Cottage
    New Lydd Road, Camber
    TN31 7QS Rye
    East Sussex
    United KingdomBritish123411450001
    VERGERSON, Jeffrey Vernon
    Hillside View
    Foxham
    SN15 4NL Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Hillside View
    Foxham
    SN15 4NL Chippenham
    Wiltshire
    British78318120001
    VERGERSON, Julie Elizabeth
    18 Windsor Park
    NR19 2SU Dereham
    Norfolk
    Amministratore
    18 Windsor Park
    NR19 2SU Dereham
    Norfolk
    British52412280001
    WATTS, David
    Half Acre Stowhill
    Childrey
    OX12 9XQ Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    Half Acre Stowhill
    Childrey
    OX12 9XQ Wantage
    Oxfordshire
    British13082830001
    WHITE, Brian Keith
    35 St Johns Road
    Grove
    OX12 7NP Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    35 St Johns Road
    Grove
    OX12 7NP Wantage
    Oxfordshire
    British31415220001
    FNCS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011820001

    Chi sono le persone con controllo significativo di COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Thames Valley Fooods
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    England
    06 apr 2016
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEanland And Wales
    Numero di registrazione02751833
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 apr 2016
    Consegnato il 28 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pamela Jane Corbett
    • Richard Gerard Heaton Corbett
    Transazioni
    • 28 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 apr 2016
    Consegnato il 21 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    No land, ships, aircraft or intellectual property.. Please see charge document for more details.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transazioni
    • 21 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 mag 2015
    Consegnato il 04 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    No land, ships, aircraft or intellectual property.. Please see charge document for more details.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transazioni
    • 04 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 mag 2015
    Consegnato il 03 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Each company with full title guarantee hereby charges its credit balances to the bank to secure repayment of the secured obligations.. Please see charge document for more details.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transazioni
    • 03 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 25 lug 2008
    Consegnato il 29 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 29 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Omnibus guarantee & set off agreement
    Creato il 25 lug 2008
    Consegnato il 29 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 lug 2008
    Consegnato il 29 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 05 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any appointee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 ott 2004
    Consegnato il 29 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter with endorsement
    Creato il 22 giu 1998
    Consegnato il 25 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The performance of the company's obligations due to the chargee under a lease dated 22 june 1998 and any of the other obligations of the company to the chargee
    Brevi particolari
    £1000 being the deposited sum and interest earned thereon and all money from time to time appropriated by the chargee therefrom in accordance with the said letter.
    Persone aventi diritto
    • Breckland District Council
    Transazioni
    • 25 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 nov 1997
    Consegnato il 02 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    COUNTRYSIDE FREE RANGE EGGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 ott 2018Data di scioglimento
    30 giu 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laurence George Russell
    Albert Goodman
    Mary Street House
    TA1 3NW Mary Street
    Taunton Somerset
    Praticante
    Albert Goodman
    Mary Street House
    TA1 3NW Mary Street
    Taunton Somerset

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0