CIVICEASY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CIVICEASY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03422540 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CIVICEASY LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CIVICEASY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di CIVICEASY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per CIVICEASY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomina di Mrs Wendy Margaret Hall come amministratore in data 01 gen 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Shepherd come amministratore in data 31 dic 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 ago 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Thorsten Beer come amministratore in data 03 set 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew John Willetts come amministratore in data 03 set 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 ago 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Nichola Louise Legg come segretario in data 25 lug 2012 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jennifer Anne Brierley come segretario in data 25 lug 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 ago 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr William Shepherd come amministratore in data 01 ago 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Smerdon come amministratore in data 01 ago 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 ago 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jennifer Anne Brierley il 01 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 ago 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CIVICEASY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGG, Nichola Louise | Segretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | 163214890001 | |||||||
| BEER, Thorsten | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| HALL, Wendy Margaret | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | 172979860001 | |||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Segretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
| HEATON, Janet Ruth | Segretario | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
| MEHDI, Mohammed | Segretario | 13 Drove Road Throckley NE15 9DS Newcastle Upon Tyne | British | 56130280001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| HOOD, John | Amministratore | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | 39644740002 | ||||||
| MAK, Yat Keung | Amministratore | 4 Careen Crescent Middle Herrington SR3 3TF Sunderland Tyne & Wear | British | 23718690001 | ||||||
| MEHDI, Mohammed | Amministratore | 13 Drove Road Throckley NE15 9DS Newcastle Upon Tyne | British | 56130280001 | ||||||
| SHEPHERD, William | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| WILLETTS, Andrew John | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 120451550002 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
CIVICEASY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 29 apr 2003 Consegnato il 13 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 43/45 frederick street and 49 walpole street south shields tyne & wear (TY174479. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 dic 1998 Consegnato il 15 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the medical centre new george street south shields..8 Sea road fulwell sunderland..191 Laygate south shields. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 08 dic 1997 Consegnato il 18 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0