CIVICEASY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCIVICEASY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03422540
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CIVICEASY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CIVICEASY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CIVICEASY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per CIVICEASY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Mrs Wendy Margaret Hall come amministratore in data 01 gen 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Shepherd come amministratore in data 31 dic 2013

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ago 2013

    Stato del capitale al 22 ago 2013

    • Capitale: GBP 2,000
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Thorsten Beer come amministratore in data 03 set 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew John Willetts come amministratore in data 03 set 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mrs Nichola Louise Legg come segretario in data 25 lug 2012

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jennifer Anne Brierley come segretario in data 25 lug 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr William Shepherd come amministratore in data 01 ago 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Smerdon come amministratore in data 01 ago 2011

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    3 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Jennifer Anne Brierley il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CIVICEASY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEGG, Nichola Louise
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    163214890001
    BEER, Thorsten
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman172030260001
    HALL, Wendy Margaret
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish172979860001
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Segretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    MEHDI, Mohammed
    13 Drove Road
    Throckley
    NE15 9DS Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    13 Drove Road
    Throckley
    NE15 9DS Newcastle Upon Tyne
    British56130280001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Amministratore
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    MAK, Yat Keung
    4 Careen Crescent
    Middle Herrington
    SR3 3TF Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    4 Careen Crescent
    Middle Herrington
    SR3 3TF Sunderland
    Tyne & Wear
    British23718690001
    MEHDI, Mohammed
    13 Drove Road
    Throckley
    NE15 9DS Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    13 Drove Road
    Throckley
    NE15 9DS Newcastle Upon Tyne
    British56130280001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CIVICEASY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 29 apr 2003
    Consegnato il 13 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    43/45 frederick street and 49 walpole street south shields tyne & wear (TY174479. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 dic 1998
    Consegnato il 15 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the medical centre new george street south shields..8 Sea road fulwell sunderland..191 Laygate south shields. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transazioni
    • 15 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 dic 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0