BTL REALISATIONS 2009 LIMITED

BTL REALISATIONS 2009 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBTL REALISATIONS 2009 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03425946
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    • (5190) /

    Dove si trova BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BERTRAM TRADING LIMITED05 lug 200505 lug 2005
    CYPHER HOLDINGS LIMITED05 mag 200005 mag 2000
    CYPHER GROUP LIMITED21 ago 199721 ago 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 feb 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 mar 2011

    21 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 11 mar 2011

    11 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 set 2010

    10 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 mar 2010

    12 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 set 2009

    12 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    47 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    46 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed bertram trading LIMITED\certificate issued on 23/03/09
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio modificato redatto al 02 feb 2008

    25 pagineAAMD

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 02 feb 2008

    25 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    6 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assistenza finanziaria per l'acquisizione di azioni

    RES07
    capital

    Risoluzioni

    Authority to execute documents 29/08/2008
    RES13

    legacy

    8 pagine155(6)a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    5 pagine395

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di BTL REALISATIONS 2009 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEEMING, Christopher
    52 Mile End Road
    NR4 7QX Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    52 Mile End Road
    NR4 7QX Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish83952290001
    GRAHAM, David John
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    Segretario
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    British75314100001
    IVEL, Nicholas
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    Segretario
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    British1036930003
    MCGONIGLE, Richard John
    Greensleeves
    Bramley Corner
    RG26 5DJ Bramley
    Segretario
    Greensleeves
    Bramley Corner
    RG26 5DJ Bramley
    British125002440001
    MILLS, Jeremy David Nash
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    Segretario
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    British92977300001
    ROBINSON, Michael John
    Lavenders 4 Drakes Loke
    Buxton
    NR10 5HU Norwich
    Norfolk
    Segretario
    Lavenders 4 Drakes Loke
    Buxton
    NR10 5HU Norwich
    Norfolk
    British60420200003
    VERSEC SECRETARIES LIMITED
    39 Alma Road
    AL1 3AT St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    39 Alma Road
    AL1 3AT St. Albans
    Hertfordshire
    79043790001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BARNETSON, Graham
    Lawn Cottages
    51 Horton Road
    SL3 9LD Datchet
    Berkshire
    Amministratore
    Lawn Cottages
    51 Horton Road
    SL3 9LD Datchet
    Berkshire
    United KingdomBritish94018550003
    BROWN, Thomas Henry Phelps
    Tibthorpe Grange
    Tibthorpe
    YO25 9LG Driffield
    East Yorkshire
    Amministratore
    Tibthorpe Grange
    Tibthorpe
    YO25 9LG Driffield
    East Yorkshire
    United KingdomBritish4055550001
    ENGLISH, Paul Robert Forster
    4 The Leys
    OX7 5HH Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    4 The Leys
    OX7 5HH Chipping Norton
    Oxfordshire
    British48135660002
    GRAHAM, David John
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    Amministratore
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    United KingdomBritish75314100001
    GRAY, Raymond John
    11 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    11 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    Yorkshire
    British58316960001
    HENDRIE, Ian Arthur
    Orchard Cottage
    Bunwell Street
    NR16 1NA Norwich
    Amministratore
    Orchard Cottage
    Bunwell Street
    NR16 1NA Norwich
    United KingdomBritish123762920001
    HORRY, David
    Byways
    The Bent, Curbur
    S32 3YD Hope Valley
    Amministratore
    Byways
    The Bent, Curbur
    S32 3YD Hope Valley
    United KingdomBritish95866490004
    HOWARD, Josephine Mary
    2 Blenheim Terrace
    OX7 5HF Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 Blenheim Terrace
    OX7 5HF Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish94643210001
    IVEL, Nicholas
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    Amministratore
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    British1036930003
    LEWIS, Stephen Bernard
    11 London Road
    Loughton Village
    MK5 8AB Milton Keynes
    Amministratore
    11 London Road
    Loughton Village
    MK5 8AB Milton Keynes
    United KingdomBritish78249540002
    MILLS, Jeremy David Nash
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    Amministratore
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    British92977300001
    NEIL, Michael Hugh
    Bourton On The Hill
    GL56 9AH Gloucester
    The Bank House
    Amministratore
    Bourton On The Hill
    GL56 9AH Gloucester
    The Bank House
    United KingdomBritish129915950001
    NICHOLLS, Julian Frederick
    The Thatched Cottage
    Smiths End Lane Barley
    SG8 8LH Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Thatched Cottage
    Smiths End Lane Barley
    SG8 8LH Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish95086050001
    REILLY, Terence Michael
    Hillside
    Barrack Hill
    HP7 0LW Coleshill
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hillside
    Barrack Hill
    HP7 0LW Coleshill
    Buckinghamshire
    EnglandBritish88886600001
    ROBINSON, Michael John
    Holly Tree House
    Skipwith Road Escrick
    YO19 6JT York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Holly Tree House
    Skipwith Road Escrick
    YO19 6JT York
    North Yorkshire
    EnglandBritish115823780001
    WIGGLESWORTH, Lloyd John
    Latton
    Cricklade
    SN6 6DP Swindon
    Latton House
    England
    Amministratore
    Latton
    Cricklade
    SN6 6DP Swindon
    Latton House
    England
    EnglandBritish128029980001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    BTL REALISATIONS 2009 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 mag 2008
    Consegnato il 03 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 03 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Book debts debenture
    Creato il 27 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge all purchased debts together with their related rights,and by way of floating charge the other debts together with their related rights and such moneys which the company may receive in respect of the other debts.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 2005
    Consegnato il 18 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land and buildings at enfield road, morley, leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 16 ago 2001
    Consegnato il 30 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any member of the group (as defined) to the chargee as security trusteee for the security beneficiaries (as defined) (the "security trustee") whether pursuant to the a loan note instrument, the b loan note instrument, the a notes, the b notes, the guarantee (all as defined) or otherwise on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rowan Nominees Limited
    Transazioni
    • 30 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 feb 1999
    Consegnato il 17 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries) whether pursuant to the loan note instrument, the notes, guarantee or otherwise
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rowan Nominees Limited
    Transazioni
    • 17 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 feb 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group member (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Creato il 03 feb 1999
    Consegnato il 10 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policies and all monies including bonuses accrued or which may at any time accrue which shall become payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 feb 1999
    Consegnato il 10 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 feb 1998
    Consegnato il 19 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all debts (purchased or to be purchased by the security holder pursuant to the agreement) which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (as defined) pertaining to such debts and floating charge all undertaking property rights and assets of the company present and future present and future stock in trade uncalled capital not charged by way of fixed charge above.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 19 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 set 1997
    Consegnato il 26 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of a subscription agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited (As Security Trustee for Itself and the Investors)
    Transazioni
    • 26 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 set 1997
    Consegnato il 19 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BTL REALISATIONS 2009 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 mar 2011Fine dell'amministrazione
    20 mar 2009Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Best
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Praticante
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Praticante
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0