COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD

COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03426633
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?

    • Attività di organizzazioni professionali di categoria (94120) / Altre attività di servizi

    Dove si trova COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Rossington's Business Park
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COBRA CAPITAL RELEASE LIMITED19 feb 200819 feb 2008
    BKG MORTGAGES LIMITED27 lug 200227 lug 2002
    BKG PROPERTIES LIMITED22 nov 200122 nov 2001
    BURROWS KEITH PROPERTIES LIMITED29 ago 199729 ago 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Redgwell il 13 gen 2022

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Carl Lloyd Mcmillan come amministratore in data 13 gen 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Gavin Matthew Perkins come amministratore in data 13 gen 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Steven Redgwell come amministratore in data 13 gen 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Brendan James Mcmanus come amministratore in data 13 gen 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ryan Christopher Brown come amministratore in data 13 gen 2022

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020

    11 pagineAA

    legacy

    96 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michael Bowler come amministratore in data 09 dic 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    8 pagineAA

    legacy

    88 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Modifica dei dettagli di Cobra Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Cobra Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 22 ago 2020

    2 paginePSC05

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2020 al 31 dic 2019

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di David George Edward Stanley come amministratore in data 01 dic 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCMILLAN, Carl Lloyd
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish291243280001
    PERKINS, Gavin Matthew
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish291367680001
    REDGWELL, Steven
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish226334320002
    BOWLER, Michael
    Morley Road
    Sanderstead
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    Segretario
    Morley Road
    Sanderstead
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    British13539620002
    DIXON, Janet Bryan
    Las Mercedes 32 Twinoaks
    KT11 2QP Cobham
    Surrey
    Segretario
    Las Mercedes 32 Twinoaks
    KT11 2QP Cobham
    Surrey
    British30326330001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    Segretario
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    34893920004
    WILLOW TAXATION & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1st Floor Curzon House
    24 High Street
    SM7 2LJ Banstead
    Surrey
    Segretario
    1st Floor Curzon House
    24 High Street
    SM7 2LJ Banstead
    Surrey
    111052920001
    BOWLER, Michael
    Morley Road
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    England
    Amministratore
    Morley Road
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    England
    EnglandBritish13539620002
    BOWLER, Michael
    Morley Road
    Sanderstead
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    Amministratore
    Morley Road
    Sanderstead
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    EnglandBritish13539620002
    BRIGHT, Peter John
    Buckingham Way
    SM6 9LU Wallington
    55
    Surrey
    Amministratore
    Buckingham Way
    SM6 9LU Wallington
    55
    Surrey
    EnglandBritish110864550001
    BROWN, Ryan Christopher
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish287066760001
    BURROWS, Stephen Mark
    Firdale
    East Parkside Great Park
    CR6 9PZ Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    Firdale
    East Parkside Great Park
    CR6 9PZ Warlingham
    Surrey
    United KingdomBritish13539590001
    KEITH, Colin Reginald
    Heath Cottage Colley Lane
    RH2 9DD Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Heath Cottage Colley Lane
    RH2 9DD Reigate
    Surrey
    British13539600001
    MCMANUS, Brendan James
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    Amministratore
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish128122260001
    POULTON, Hannah
    6 Daines Way
    SS1 3PF Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    6 Daines Way
    SS1 3PF Southend On Sea
    Essex
    British99706350001
    SAUNDERS, Stephen David
    103 Oval Road
    CR0 6BR Croydon
    Surrey
    Amministratore
    103 Oval Road
    CR0 6BR Croydon
    Surrey
    EnglandBritish83911420001
    STANLEY, David George Edward
    12 Court Meadow Close
    TN6 3LW Rotherfield
    East Sussex
    Amministratore
    12 Court Meadow Close
    TN6 3LW Rotherfield
    East Sussex
    EnglandBritish79784840001
    VERRELL, Rose Elizabeth
    46 Arundel Avenue
    CR2 8BB South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    46 Arundel Avenue
    CR2 8BB South Croydon
    Surrey
    British47301700001
    WALLIS, Lee Grant
    10 Chaucer Close
    SM7 1PP Banstead
    Surrey
    Amministratore
    10 Chaucer Close
    SM7 1PP Banstead
    Surrey
    EnglandBritish27309640002

    Chi sono le persone con controllo significativo di COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05548507
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 mar 2015
    Consegnato il 26 mar 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 set 2012
    Consegnato il 22 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Macquarie Bank Limited
    Transazioni
    • 22 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 18 feb 2009
    Consegnato il 26 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 26 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a guarantee and debenture
    Creato il 19 gen 2009
    Consegnato il 09 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 9-11 high street, alton, hampshire t/no SH12795, f/h property k/a 139 and 141 manchester road, broadheath, altrincham, cheshire t/no GM768625 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Insurance Limited
    Transazioni
    • 09 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 gen 2009
    Consegnato il 31 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other charging company to the chargee and the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wainford Holdings Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2009
    • 22 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 25 mar 1998
    Consegnato il 30 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 49 woodpecker mount and garage 55 addington L.B. of croydon t/n-SGL587114.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 dic 1997
    Consegnato il 08 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 63 bellfield addington london borough of croydon t/no: SGL171383. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0