LLNH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLLNH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03429499
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LLNH LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova LLNH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LLNH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEND LEASE NH LIMITED07 gen 199807 gen 1998
    LEND LEASE HOMES LIMITED11 set 199711 set 1997
    HACKREMCO (NO.1266) LIMITED04 set 199704 set 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di LLNH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per LLNH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Situations in which directors have or can have a direct or indirect interest that conflicts with interest of the company authorised, notwithstanding that any such conflict may breach director's duty under S175 of CA2006. 25/08/2021
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2020

    9 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 034294990011 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 034294990013 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 034294990012 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 034294990014, creata il 27 apr 2021

    57 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 034294990016, creata il 27 apr 2021

    90 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 034294990015, creata il 27 apr 2021

    216 pagineMR01

    Nomina di Mr James Walter Tugendhat come amministratore in data 14 set 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di James Justin Hutchens come amministratore in data 05 feb 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Justin Hutchens il 08 gen 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Chaitanya Bhupendra Patel come amministratore in data 22 set 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr James Justin Hutchens come amministratore in data 21 set 2017

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 034294990010 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 034294990013, creata il 30 giu 2017

    47 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di LLNH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    Amministratore
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    United KingdomBritish147997950001
    TUGENDHAT, James Walter
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Amministratore
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomBritish218306870001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    Segretario
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    British106745220001
    GOUGH, Alison Louise
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Segretario
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Australian62074540001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Segretario
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Segretario
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    KILMARTIN, Adrian Robert
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    Segretario
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    British11660010001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Segretario
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Segretario
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MORTIMER, Rachel
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    Segretario
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    British102674500002
    PANG, Lily
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Segretario
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Malaysian140239060001
    SUTTON, Penelope Ruth
    32 Saxon Road
    BR1 3RP Bromley
    Kent
    Segretario
    32 Saxon Road
    BR1 3RP Bromley
    Kent
    British38586070002
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Segretario nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    ARTHUR, Derryn Sue
    21 Elsham Road
    W14 8HA London
    Amministratore
    21 Elsham Road
    W14 8HA London
    New Zealander57726590002
    AUBERY, Paul Richard
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    Amministratore
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    British78253140001
    BARATTA, Joseph Patrick
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    Amministratore
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    UsaAmerican94259330002
    BLITZER, David Scott
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Amministratore
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    EnglandAmerican82685720001
    BURROWS, Roger Leonard
    51 Leyborne Park
    Kew
    TW9 3BH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    51 Leyborne Park
    Kew
    TW9 3BH Richmond
    Surrey
    Australian47271870002
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Amministratore
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    DAVIES, William Jeremy
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish21505070001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Amministratore
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    ELLERT, Richard John
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    Amministratore
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    British95944260001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    FRANCIS, Daniel Fernley
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish44830480001
    GOUGH, Alison Louise
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Amministratore
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Australian62074540001
    GRANT, Michael John
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    Amministratore
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    EnglandBritish141668610001
    HUTCHENS, James Justin
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Amministratore
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomAmerican238334580002
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Amministratore
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    MARSHALL, Ian
    43 Belsize Road
    NW6 4RX London
    Amministratore
    43 Belsize Road
    NW6 4RX London
    British81232950001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Amministratore
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Amministratore
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Amministratore
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LLNH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Nhp Limited
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    Durham
    England
    01 mag 2017
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    Durham
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione02798607
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    LLNH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 apr 2021
    Consegnato il 29 apr 2021
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 29 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 apr 2021
    Consegnato il 29 apr 2021
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 29 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 apr 2021
    Consegnato il 29 apr 2021
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 29 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 giu 2017
    Consegnato il 10 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 10 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 giu 2017
    Consegnato il 07 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 07 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 giu 2017
    Consegnato il 06 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 06 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 nov 2014
    Consegnato il 21 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hcp, Inc. (As Security Agent)
    Transazioni
    • 21 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security deed
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 30 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, London Branch
    Transazioni
    • 30 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture
    Creato il 12 dic 2006
    Consegnato il 21 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ott 2005
    Consegnato il 20 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 20 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2005
    Consegnato il 15 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 15 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 11 giu 1998
    Consegnato il 18 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture)
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage f/h interest in aberford hall nursing home oakwood green roundhay leeds LS8 2QU t/n-WYK510482, ascot lodge nursing home 48A newlands road intake sheffield S12 2FZ t/n-SYK354711, aston house nursing home 26 angel lane hayes middlesex UB3 2QX t/n-NGL47781 (see 395 for other properties charged).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transazioni
    • 18 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 03 giu 1998
    Consegnato il 08 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Each and every liability that the obligors (as therein defined) may have to the chargee under or pursuant to the facility documents (as defined in the facility agreement dated 28 january 1998) (including the facility agreement and the debenture dated 28 january 1998)
    Brevi particolari
    The f/h interest in the property k/a ashton grange residential home st lukes road pallion sunderland t/n TY304629, windsor court bartholomew avenue goole east riding of yorkshire t/n HS170159, ashbourne lodge nursing home ryhope road grangetown sunderland t/n TY310171 and victoria house residential home bath lane stockton on tees t/n CE136807 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for Itself and the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 08 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture made between (1) llnhp partnership acting through its partners (2) nhp securities no.4 Limited and (3) lend lease nh limited in favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee
    Creato il 06 mag 1998
    Consegnato il 11 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture)
    Brevi particolari
    All rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property k/a the beeches nursing home 55 furlong road arnold nottingham. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 10 feb 1998
    Consegnato il 24 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Each and every liability which the obligors (as therein defined) have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture dated 28 january 1998) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum now or hereafter owing due or incurred by the obligors to the security trustee or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Brevi particolari
    All rights and claims in relation to the real property being - the f/h ladymead nursing home canal way devizes wiltshire t/n WT133199 avonmead nursing home canal way devises wiltshire t/n's WT132231, WT142939 and WT154929 and kingsmead nursing home prospect place old town swindon wiltshire t/n's WT16064, WT139496 and WT137926. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandthe "Security Trustee"
    Transazioni
    • 24 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 gen 1998
    Consegnato il 03 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Each and every liability which the obligors (as defined) have to the governor and company of the bank of scotland (the security trustee) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents (as defined) (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum at the date of the debenture or thereafter owing by the obligors to the security trustee or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Brevi particolari
    A.the real property other than scottish real property and the northern irish real property;B.all rights and claims to which llnhp and each partner is at the date of the debenture or may thereafter become entitled in relation to all monies at the date of the debenture or at any time standing to the credit of any bank accounts.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0