ACCESS HOMECARE LIMITED

ACCESS HOMECARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACCESS HOMECARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03433621
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACCESS HOMECARE LIMITED?

    • (8532) /

    Dove si trova ACCESS HOMECARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACCESS HOMECARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per ACCESS HOMECARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Angela Culhane come amministratore in data 25 giu 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    17 pagineAA

    Nomina di Jonathan David Calow come segretario in data 08 dic 2011

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Care Uk Services Ltd come segretario in data 08 dic 2011

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 set 2011

    Stato del capitale al 20 set 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    17 pagineAA

    Nomina di Paul John Watson come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Justin Humphreys il 01 set 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Care Uk Services Ltd il 01 set 2010

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Robert Parish il 10 ago 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01

    legacy

    28 pagineMG01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    20 pagineAA

    Nomina di Deborah Jane Marriott-Boam come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Geoffrey Benn come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Douglas Umbers come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Angela Hector Culhane come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Roy Hastings come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di ACCESS HOMECARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CALOW, Jonathan David
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Segretario
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    165428570001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritishDirector33223550003
    MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director151689670001
    PARISH, Michael Robert
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritishDirector78828750003
    WATSON, Paul John
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritishAccountant82460360003
    HORROCKS, Stephen Kevin
    Farnborough Road
    BL1 7HJ Bolton
    25
    Lancashire
    United Kingdom
    Segretario
    Farnborough Road
    BL1 7HJ Bolton
    25
    Lancashire
    United Kingdom
    British128758490001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    BritishDirector33223550003
    CARE UK SERVICES LTD
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2482660
    125241530002
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishCompany Director73786580001
    BOOKER, Roger Ian
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    Amministratore
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector14044530003
    CULHANE, Angela
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritishCompany Director68602910001
    HASTINGS, Roy
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    Amministratore
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director130098430001
    QUINN, David Laurence, Mr.
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director123356660001
    TRAYNOR, Shirlie Rose
    19 Burnedge Lane
    Grasscroft
    OL4 4EA Oldham
    Amministratore
    19 Burnedge Lane
    Grasscroft
    OL4 4EA Oldham
    United KingdomBritishManaging Director54634440002
    UMBERS, Douglas
    Tyrrel House
    Tyrrel Road Chandlers Ford
    SO53 1GG Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    Tyrrel House
    Tyrrel Road Chandlers Ford
    SO53 1GG Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director90541690001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    Amministratore
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    EnglandBritishCompany Director130512090002

    ACCESS HOMECARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 lug 2010
    Consegnato il 26 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 26 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 10 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 10 mag 2002
    Consegnato il 18 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    97-111 turner lane ashton under lyne. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 gen 2002
    Consegnato il 26 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0