RELAND (WEEDON) LIMITED

RELAND (WEEDON) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRELAND (WEEDON) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03435816
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RELAND (WEEDON) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAVALRY CENTRE LIMITED20 nov 199720 nov 1997
    HUNTERMILE LIMITED18 set 199718 set 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Jonathan Ross Brodie come amministratore in data 31 dic 2015

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Ross Brodie il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP in data 23 ott 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 set 2015

    Stato del capitale al 07 set 2015

    • Capitale: GBP 32
    SH01

    Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 15 dic 2014

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 set 2014

    Stato del capitale al 08 set 2014

    • Capitale: GBP 32
    SH01

    Cessazione della carica di Elizabeth Catchpole come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Segretario
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147811200001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Segretario
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    British35117250001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Segretario nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    TAYLOR, David John
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    Segretario
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    British136521790001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritish62279790001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Amministratore
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Amministratore
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CURRAN, Paul
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish110978610002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Amministratore delegato nominato
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MILLIGAN, Michael
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish153845120001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002

    RELAND (WEEDON) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A bond and floating charge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 14 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 14 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 14 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the each obligor and each residential obligor to any commercial secured party and any residential secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 14 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2009
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 09 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 lug 2000
    Consegnato il 27 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 nov 1997
    Consegnato il 03 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 nov 1997
    Consegnato il 03 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0