STOCKFLAG LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTOCKFLAG LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03437935
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STOCKFLAG LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova STOCKFLAG LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di STOCKFLAG LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per STOCKFLAG LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Tim Ørting Jørgensen come amministratore in data 03 mag 2022

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Ajoy Hari Karna come amministratore in data 04 lug 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Tim Ørting Jørgensen come amministratore in data 04 lug 2021

    2 pagineAP01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di David Robert Lodge come amministratore in data 30 giu 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Ajoy Hari Karna come amministratore in data 30 giu 2021

    2 pagineAP01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 giu 2021

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 28 giu 2021

    • Capitale: GBP 6,336,598.22
    5 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STOCKFLAG LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHIBLEY, Sarah Leanne
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    Segretario
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    197289950001
    WHIBLEY, Sarah Leanne
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    Amministratore
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    EnglandBritish197579800001
    BOUTEL, Alan John
    Steart Farm
    North Marston
    MK18 3LD Buckingham
    Buckinghamshire
    Segretario
    Steart Farm
    North Marston
    MK18 3LD Buckingham
    Buckinghamshire
    British28733880002
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    Segretario
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    ROGERS, James Julian
    73 Fairacres Road
    OX4 1TQ Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    73 Fairacres Road
    OX4 1TQ Oxford
    Oxfordshire
    British50387640001
    WHITEHEAD, Adrian John, Mr,
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Segretario
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    British83031020003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ANGEL, Peter George
    11 Field House Drive
    OX2 7NT Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    11 Field House Drive
    OX2 7NT Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish4761510002
    ARCHER, Jeffrey Onslow
    Westlington House
    Dinton
    HP17 8TX Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Westlington House
    Dinton
    HP17 8TX Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish55720720001
    ARCHER, Marion Yvonne
    Westlington House
    Oxford Road Dinton
    HP17 8TX Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Westlington House
    Oxford Road Dinton
    HP17 8TX Aylesbury
    Buckinghamshire
    British3063570002
    BOUTEL, Alan John
    Steart Farm
    North Marston
    MK18 3LD Buckingham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Steart Farm
    North Marston
    MK18 3LD Buckingham
    Buckinghamshire
    British28733880002
    BRAKE, Christopher
    Fairlawn House
    Eyhurst
    KT20 6JN Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Fairlawn House
    Eyhurst
    KT20 6JN Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritish90432200001
    DESCHAMPS, Bruno
    14 Brompton Square
    SW3 2AA London
    Amministratore
    14 Brompton Square
    SW3 2AA London
    French86579020003
    DRISCOLL, William
    Lanscombe House
    Nun's Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Lanscombe House
    Nun's Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    Irish American92975240001
    FEARN, Matthew Robin Cyprian
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    United KingdomBritish109155280002
    GARLICK, Helen
    6 Lambly Hill
    GU25 4BF Virginia Water
    Amministratore
    6 Lambly Hill
    GU25 4BF Virginia Water
    British88752280001
    HARTE, Damian
    29 East Avenue
    Talbot Wood
    BH3 7BS Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    29 East Avenue
    Talbot Wood
    BH3 7BS Bournemouth
    Dorset
    Irish95779320001
    HAYTER, George Anthony
    The Old Vicarage
    Maisemore
    GL12 8HU Gloucester
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Maisemore
    GL12 8HU Gloucester
    United KingdomBritish160301340001
    HUGHES, Leonard
    50 St Margarets Street
    ME1 1TU Rochester
    Kent
    Amministratore
    50 St Margarets Street
    ME1 1TU Rochester
    Kent
    British52234370002
    JØRGENSEN, Tim Ørting, Mr.
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    EnglandDanish285447210001
    KARNA, Ajoy Hari
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    United StatesAmerican232771480001
    LODGE, David Robert
    Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    Amministratore
    Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    United KingdomBritish164083200001
    MCKAY, Francis John
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    Amministratore
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    British110371430001
    PARKER, Christopher John
    30 Main Street
    MK17 0RT Mursley
    Buckinghamshire
    Amministratore
    30 Main Street
    MK17 0RT Mursley
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish91475230002
    PERRY, Nigel Peter
    Middle Willow
    Maidstone Road
    TN15 8JE St Mary's Platt
    Kent
    Amministratore
    Middle Willow
    Maidstone Road
    TN15 8JE St Mary's Platt
    Kent
    British101033740001
    PLAYER, Michael Ian
    Whitelea
    Shootersway Lane
    HP4 3NP Berkamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Whitelea
    Shootersway Lane
    HP4 3NP Berkamsted
    Hertfordshire
    British11860001
    POWER, Ian Derek
    13 Turketel Road
    CT20 2PA Folkestone
    Kent
    Amministratore
    13 Turketel Road
    CT20 2PA Folkestone
    Kent
    United KingdomBritish107471150001
    VEALE, Stuart Michael
    34 Galveston Road
    SW15 2SA London
    Amministratore
    34 Galveston Road
    SW15 2SA London
    British55936180002
    VENABLES, Paul
    37 Ancastle Green
    RG9 1TS Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    37 Ancastle Green
    RG9 1TS Henley On Thames
    Oxfordshire
    British103911420001
    WHITEHEAD, Adrian John, Mr,
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    EnglandBritish83031020003
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di STOCKFLAG LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brake Bros Limited
    Nicholas Road, Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    England
    06 apr 2016
    Nicholas Road, Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Acts
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies
    Numero di registrazione02035315
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    STOCKFLAG LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 nov 2015
    Consegnato il 16 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent (As Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 16 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 nov 2015
    Consegnato il 03 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent (As Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 03 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 mag 2014
    Consegnato il 11 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent (As Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 11 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 nov 2013
    Consegnato il 29 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent (As Trustee for Each Secured Party)
    Transazioni
    • 29 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture accession deed
    Creato il 10 dic 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    The global form of deed of accession
    Creato il 25 set 2002
    Consegnato il 09 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge, all its right, title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the material intellectual property, any goodwill and rights in relation to the unca. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited as Security Trustee (Whether for Its Own Account or as Trustee Forthe Secured Creditors)
    Transazioni
    • 09 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 01 dic 1997
    Consegnato il 12 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from stockflag limited (the borrower) and m&j seafoods (wholesale) limited (the original subsidiaries) to the chargee under or pursuant to the secured documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0