PCV BRACKNELL LIMITED

PCV BRACKNELL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPCV BRACKNELL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03439399
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PCV BRACKNELL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PCV BRACKNELL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PCV BRACKNELL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FREEHOLD PORTFOLIOS BRACKNELL LIMITED19 set 199719 set 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di PCV BRACKNELL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per PCV BRACKNELL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 17 set 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 ago 2012

    Stato del capitale al 03 ago 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Leonard Grose il 18 gen 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di David Leonard Grose come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alasdair Evans come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di PCV BRACKNELL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUMM, Sandra Louise
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Segretario
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Australian57113450003
    GROSE, David Leonard
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House
    Amministratore
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House
    United KingdomBritishAccountant120479020002
    GUMM, Sandra Louise
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Amministratore
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    EnglandAustralianChartered Accountant57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Amministratore
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    United KingdomBritishChartered Surveyor6815470021
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    Amministratore
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritishChartered Accntant155262770001
    LINEOBTAIN LIMITED
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    Segretario
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    87536870003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector Of Tax100504300001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Amministratore
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant108586450001
    EVANS, Alasdair David
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    Amministratore
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    United KingdomBritishDirector130019430001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    BritishChartered Surveyor33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    BritishChartered Accountant93017010002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Amministratore
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritishProperty Investor38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Amministratore
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritishChartered Accountant39329840001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Amministratore
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant4779170003

    PCV BRACKNELL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture between the company (formerly known as freehold portfolios bracknell limited) each chargor and the security trustee
    Creato il 09 feb 2000
    Consegnato il 21 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whather actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to a). Each senior finance party under each senior finance document; or b). Each mezzanine finance party under each mezzanine finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985.
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutchen Bank, London Branch(As Agent and Trustee for the Senior Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties)
    Transazioni
    • 21 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 lug 1999
    Consegnato il 20 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies whatsoever due or to become due from each borrower (as defined) and fp financial to each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft,London Branch,as Agent and Trustee for Thefinance Parties
    Transazioni
    • 20 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 30 mar 1999
    Consegnato il 20 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) (the "agent") under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land k/a westerly point market street bracknell t/no: 3439399. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 20 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 gen 1999
    Consegnato il 19 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined)under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land k/a westerly point market street bracknell t/no: BK231197 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transazioni
    • 19 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of charge
    Creato il 03 nov 1997
    Consegnato il 18 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest to all monies payable under the occupational lease/s in respect of westerly point market street bracknell berkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(As Trustee for Itself and the Other Lenders)
    Transazioni
    • 18 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1997
    Consegnato il 18 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Westerly point market street bracknell berkshire t/n BK231197 together with all buildings and fixtures the benefit of all leases and covenants affecting the same all monies deposited with the trustee. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(As Trustee for Itself and the Other Lenders)
    Transazioni
    • 18 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0