BLUE 26 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLUE 26 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03439738
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLUE 26 LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova BLUE 26 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLUE 26 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GAME LIMITED22 apr 199822 apr 1998
    WAKEZONE LIMITED25 set 199725 set 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLUE 26 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 gen 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BLUE 26 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per BLUE 26 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed game LIMITED\certificate issued on 16/05/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    16 mag 2014

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM04 - MEANS IN ARTICLES

    CONNOT

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Vivienne Hemming come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Peter Crowne come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 29 gen 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 set 2011

    Stato del capitale al 30 set 2011

    • Capitale: GBP 738,300
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    24 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 25 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 gen 2010

    12 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 gen 2009

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 gen 2008

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di BLUE 26 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHITE, Benjamin
    The Row
    Redlynch
    SP5 2JT Nr Salisbury
    Anvil Cottage
    Hampshire
    Uk
    Amministratore
    The Row
    Redlynch
    SP5 2JT Nr Salisbury
    Anvil Cottage
    Hampshire
    Uk
    EnglandBritish133790090002
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Segretario
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 St Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Segretario
    25 St Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British125932650001
    WARRAN-SMITH, Nicholas Edgar
    Combe House Wadhurst Park
    TN5 6NT Wadhurst
    East Sussex
    Segretario
    Combe House Wadhurst Park
    TN5 6NT Wadhurst
    East Sussex
    Other49352480002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    CLIPSHAM, David Alan
    84 Warwick Avenue
    W9 2PU London
    Amministratore
    84 Warwick Avenue
    W9 2PU London
    British68108630001
    CROWNE, Peter Charles
    Fitzroy Road
    GU51 4JW Fleet
    38
    Hampshire
    Uk
    Amministratore
    Fitzroy Road
    GU51 4JW Fleet
    38
    Hampshire
    Uk
    United KingdomBritish106991580002
    DRURY, Simon Michael
    57 Clapham Common Westside
    Clapham
    SW4 9AT London
    Amministratore
    57 Clapham Common Westside
    Clapham
    SW4 9AT London
    British41191630002
    DUGDALE, David John
    Icomb Bank
    Icomb
    GL54 1JD Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Icomb Bank
    Icomb
    GL54 1JD Cheltenham
    Gloucestershire
    British98118020001
    FFITCH, Simon Kenneth
    The Old Vicarage
    Parrotts Lane
    HP23 6ND Cholesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Parrotts Lane
    HP23 6ND Cholesbury
    Buckinghamshire
    British102711200001
    FRENDO, Paul Anthony
    32 Holloway Drive
    Crossland House
    GU25 4SY Virginia Park Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    32 Holloway Drive
    Crossland House
    GU25 4SY Virginia Park Virginia Water
    Surrey
    British38495050003
    GAWTHORNE, Mark David
    10 Gardner Way
    Chandlers Ford
    SO53 1JL Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    10 Gardner Way
    Chandlers Ford
    SO53 1JL Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish117119930001
    LEWIS, Peter Donald
    Broadacre Ismays Road
    Ightham
    TN15 9BE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Broadacre Ismays Road
    Ightham
    TN15 9BE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish55096310002
    LLOYD-ROACH, Paul
    Wyke Green Farm Soalwood Lane
    Froxfield
    GU32 1DZ Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    Wyke Green Farm Soalwood Lane
    Froxfield
    GU32 1DZ Petersfield
    Hampshire
    British58363500002
    LONG, Martin
    Flyford
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Flyford
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish125885350001
    STEINBRECHER, John Mark
    27 St Andrews Gardens
    KT11 1HG Cobham
    Surrey
    Amministratore
    27 St Andrews Gardens
    KT11 1HG Cobham
    Surrey
    American43688810003
    TAYLOR, Neil
    3 Fownes Street
    IRISH Dublin 2
    Ireland
    Amministratore
    3 Fownes Street
    IRISH Dublin 2
    Ireland
    IrelandBritish58363680001
    THOMAS, David Fraser
    Farm Drive
    The Webb Estate
    CR8 3LP Purley
    Woodlands
    Surrey
    Amministratore
    Farm Drive
    The Webb Estate
    CR8 3LP Purley
    Woodlands
    Surrey
    EnglandBritish27763020003
    WARRAN-SMITH, Nicholas Edgar
    Combe House Wadhurst Park
    TN5 6NT Wadhurst
    East Sussex
    Amministratore
    Combe House Wadhurst Park
    TN5 6NT Wadhurst
    East Sussex
    Other49352480002
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    BLUE 26 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 mag 2007
    Consegnato il 11 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (In Such Capacity,the 'Security Trustee')
    Transazioni
    • 11 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mag 2000
    Consegnato il 12 giu 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 giu 1999
    Consegnato il 13 lug 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (including the guarantee and debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0