IMCO RECONOMY 7 LIMITED

IMCO RECONOMY 7 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIMCO RECONOMY 7 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03441128
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IMCO RECONOMY 7 LIMITED?

    • Raccolta di rifiuti non pericolosi (38110) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica

    Dove si trova IMCO RECONOMY 7 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kelsall House Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Shropshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IMCO RECONOMY 7 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WASTE HIRE SERVICES LIMITED08 gen 199808 gen 1998
    BROOMCO (1380) LIMITED29 set 199729 set 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di IMCO RECONOMY 7 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per IMCO RECONOMY 7 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 28 giu 2018

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Stato del capitale al 17 apr 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 23/03/2018
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Coldbath Square London EC1R 5HL a Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD in data 25 lug 2016

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 034411280006 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr John Sullivan come segretario in data 21 lug 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Llewelyn Milnes-James come amministratore in data 21 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles Nicholas Pollard come amministratore in data 21 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alistair Myrie Holl come amministratore in data 21 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Caroline Elizabeth Allen come segretario in data 21 lug 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr John Terence Sullivan come amministratore in data 21 lug 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Cox come amministratore in data 21 lug 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    15 pagineAA

    Nomina di Ms Caroline Elizabeth Allen come segretario in data 01 apr 2016

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di IMCO RECONOMY 7 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SULLIVAN, John
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Segretario
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    210794790001
    COX, Paul Anthony
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Amministratore
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritishCompany Director153797870001
    SULLIVAN, John Terence
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Amministratore
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritishChartered Accountant180046340001
    ALLEN, Caroline Elizabeth
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    207873160001
    DIXON, Sally Veronica
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    British105363350001
    JESKE, Riga
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    189289610001
    KAHVECI, Suheda
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    176234890001
    PHILLIPS, Elizabeth Clare
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British56302980001
    REED, Sophie Catherine Jane
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    198173020001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    32524900007
    DIXON, Sally Veronica
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    Amministratore
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    EnglandBritishDirector105363350001
    GERSTROM, Peter Anton
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritishCompany Director138719750001
    HARRISON, Julian John
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritishDirector123927990001
    HOLL, Alistair Myrie
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    WalesBritishDirector138014840001
    JOHNSON, Peter Stuart
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    Amministratore
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    EnglandBritishDirector11159620001
    MILNES-JAMES, Richard Llewelyn
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritishFinance Director140753960001
    PHILLIPS, John
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director343070001
    POLLARD, Charles Nicholas
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritishDirector192011710001
    RIDDLE, David Ellison
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    EnglandBritishDirector556710002
    STEGGLES, Jonathan David
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritishDirector45141530001
    WARD, Malcolm John
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritishDirector57775660003
    WILLACY, Richard Johannes Ormerod
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    United KingdomBritishDirector92108930002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IMCO RECONOMY 7 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Reconomy (Uk) Limited
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    21 lug 2016
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House, Uk
    Numero di registrazione02951661
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    IMCO RECONOMY 7 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 ago 2015
    Consegnato il 27 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental common debenture
    Creato il 29 nov 2011
    Consegnato il 08 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 18 mag 2007
    Consegnato il 25 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 01 mar 1999
    Consegnato il 17 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 17 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mar 1999
    Consegnato il 06 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • David John Dixonacting for Himself and as Trustee for the Holders of the Loan Notes Being a Series of Up to £400,000 Created by the Company Constituted by a Trust Deed of Even Date Between Company and Chargee
    Transazioni
    • 06 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0