IMCO RECONOMY 7 LIMITED
Panoramica
Nome della società | IMCO RECONOMY 7 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03441128 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IMCO RECONOMY 7 LIMITED?
- Raccolta di rifiuti non pericolosi (38110) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica
Dove si trova IMCO RECONOMY 7 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Shropshire England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IMCO RECONOMY 7 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
WASTE HIRE SERVICES LIMITED | 08 gen 1998 | 08 gen 1998 |
BROOMCO (1380) LIMITED | 29 set 1997 | 29 set 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IMCO RECONOMY 7 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per IMCO RECONOMY 7 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||||||
Stato del capitale al 17 apr 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Coldbath Square London EC1R 5HL a Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD in data 25 lug 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 034411280006 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Nomina di Mr John Sullivan come segretario in data 21 lug 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Llewelyn Milnes-James come amministratore in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Charles Nicholas Pollard come amministratore in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Alistair Myrie Holl come amministratore in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Caroline Elizabeth Allen come segretario in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Mr John Terence Sullivan come amministratore in data 21 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Paul Cox come amministratore in data 21 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Ms Caroline Elizabeth Allen come segretario in data 01 apr 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di IMCO RECONOMY 7 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULLIVAN, John | Segretario | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | 210794790001 | |||||||
COX, Paul Anthony | Amministratore | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Company Director | 153797870001 | ||||
SULLIVAN, John Terence | Amministratore | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Chartered Accountant | 180046340001 | ||||
ALLEN, Caroline Elizabeth | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 207873160001 | |||||||
DIXON, Sally Veronica | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | British | 105363350001 | ||||||
JESKE, Riga | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 189289610001 | |||||||
KAHVECI, Suheda | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 176234890001 | |||||||
PHILLIPS, Elizabeth Clare | Segretario | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 56302980001 | ||||||
REED, Sophie Catherine Jane | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 198173020001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | 32524900007 | |||||||
DIXON, Sally Veronica | Amministratore | 22 Ardleigh Road N1 4HP London | England | British | Director | 105363350001 | ||||
GERSTROM, Peter Anton | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | Company Director | 138719750001 | ||||
HARRISON, Julian John | Amministratore | 24 Havelock Road SY3 7NE Shrewsbury Salop | England | British | Director | 123927990001 | ||||
HOLL, Alistair Myrie | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | Wales | British | Director | 138014840001 | ||||
JOHNSON, Peter Stuart | Amministratore | The Old Post Office Church Road West Peckham ME18 5JL Maidstone Kent | England | British | Director | 11159620001 | ||||
MILNES-JAMES, Richard Llewelyn | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Finance Director | 140753960001 | ||||
PHILLIPS, John | Amministratore | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | Company Director | 343070001 | |||||
POLLARD, Charles Nicholas | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | Director | 192011710001 | ||||
RIDDLE, David Ellison | Amministratore | 3 Lovelace Road KT6 6NS Surbiton Surrey | England | British | Director | 556710002 | ||||
STEGGLES, Jonathan David | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Director | 45141530001 | ||||
WARD, Malcolm John | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Director | 57775660003 | ||||
WILLACY, Richard Johannes Ormerod | Amministratore | Wraymead 158 Croydon Road RH2 0NG Reigate Surrey | United Kingdom | British | Director | 92108930002 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IMCO RECONOMY 7 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reconomy (Uk) Limited | 21 lug 2016 | Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
IMCO RECONOMY 7 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 20 ago 2015 Consegnato il 27 ago 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A supplemental common debenture | Creato il 29 nov 2011 Consegnato il 08 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession | Creato il 18 mag 2007 Consegnato il 25 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 apr 2005 Consegnato il 11 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
All assets debenture | Creato il 01 mar 1999 Consegnato il 17 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 01 mar 1999 Consegnato il 06 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0