TRIBAL NC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRIBAL NC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03442665
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRIBAL NC LIMITED?

    • Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TRIBAL NC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kings Orchard Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRIBAL NC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NEWCHURCH LIMITED04 ott 200004 ott 2000
    AGORA HEALTHCARE SERVICES LIMITED01 ott 199701 ott 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRIBAL NC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TRIBAL NC LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TRIBAL NC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Stato del capitale al 28 gen 2016

    • Capitale: GBP 0.01
    4 pagineSH19

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium & other reserves reduced 18/12/2015
    RES13

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Robert Charles Garner come amministratore in data 01 lug 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Keith Martin Evans come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2015

    Stato del capitale al 31 mar 2015

    • Capitale: GBP 17,415,052.29212
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Derrick Breach il 05 giu 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR a Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ in data 04 ago 2014

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2014

    Stato del capitale al 31 mar 2014

    • Capitale: GBP 17,415,052.29212
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 87-91 Newman Street London W1T 3EY* in data 09 mar 2012

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Lorraine Davis come segretario

    1 pagineTM02

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed newchurch LIMITED\certificate issued on 24/05/11
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name24 mag 2011

    Risoluzione di cambio di nome della società il 20 mag 2011

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Nomina di Dr Keith Martin Evans come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TRIBAL NC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BREACH, Stephen Derrick
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Amministratore
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritish174695940001
    GARNER, Robert Charles
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    Amministratore
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    United KingdomBritish53391420003
    ANDO, Daniella
    30 Concord Court
    Winery Lane
    KT1 3GF Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    30 Concord Court
    Winery Lane
    KT1 3GF Kingston Upon Thames
    Surrey
    British51693570001
    COLLINS, Richard Hawke
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Segretario
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    British136546790001
    DAVIS, Lorraine Anne
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Segretario
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    150939960001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    Segretario
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    HARMES, David Orlando Spencer
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    British60400060001
    HERCUS, Ivan Lindsay
    6 Beaumont Crescent
    W14 9LX London
    Segretario
    6 Beaumont Crescent
    W14 9LX London
    British116757120001
    MANNING, Kingsley Guy
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    Segretario
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    British15931310001
    MANNING, Kingsley Guy
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    Segretario
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    British15931310001
    WARNER, Evelyn Patricia
    Robin Hill Drive
    GU15 1EG Camberley
    23
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Robin Hill Drive
    GU15 1EG Camberley
    23
    Surrey
    United Kingdom
    British129486480001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    CONAGHAN, John Edward, Mr.
    11 Danegeld Place
    PE9 2AF Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    11 Danegeld Place
    PE9 2AF Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish97327390002
    DEWEY, Kevin
    Oak Tree Cottage 18 Meadway
    KT10 9HF Esher
    Surrey
    Amministratore
    Oak Tree Cottage 18 Meadway
    KT10 9HF Esher
    Surrey
    British6631200001
    EVANS, Keith Martin, Dr
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Amministratore
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    United KingdomBritish159812510001
    FIELD, Andrew
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Amministratore
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish61471170001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    Amministratore
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    GODBER, Stephen Alison
    41-51 Brighton Road
    RH1 6YS Redhill
    Surrey
    Amministratore
    41-51 Brighton Road
    RH1 6YS Redhill
    Surrey
    United KingdomBritish105071600001
    HARMES, David Orlando Spencer
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish60400060001
    HINE, Duncan, Dr
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    Amministratore
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    British13396990001
    KANTER, Ralph Thomas Ludwig
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    Amministratore
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    United KingdomBritish124153720001
    KEY, Simon Robert
    4 Old Street
    SP4 8JT Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    4 Old Street
    SP4 8JT Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish41514390002
    KHAN, Junaid
    33 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    Amministratore
    33 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    British98917630001
    LAMBERT, Susan
    20 Pinel Close
    Virginia Park
    GU25 4SP Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    20 Pinel Close
    Virginia Park
    GU25 4SP Virginia Water
    Surrey
    British113974450001
    LAWTON, Simon Marcus
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Amministratore
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish68807890004
    MANNING, Kingsley Guy
    22a Jacobs Well Mews
    W1U 3DR London
    Amministratore
    22a Jacobs Well Mews
    W1U 3DR London
    United KingdomBritish15931310003
    MARTIN, Nicholas Rupert Zelenka
    123 Mallinson Road
    SW11 1BH London
    Amministratore
    123 Mallinson Road
    SW11 1BH London
    British23175310002
    MARTIN, Peter John
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Amministratore
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish176044430001
    SALLIS, David
    42 Sheen Park
    TW9 1UW Richmond
    Surrey
    Amministratore
    42 Sheen Park
    TW9 1UW Richmond
    Surrey
    United KingdomUk44780590002
    SETCHELL, Brenda Carol
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Amministratore
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United KingdomBritish90477860001
    STONE, Lisa Jane
    The Grange
    Sandhill Lane, Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    The Grange
    Sandhill Lane, Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish69455810002
    TOLLEY, Robyn William
    The Old Barn
    Blithbury
    WS15 3JG Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    The Old Barn
    Blithbury
    WS15 3JG Rugeley
    Staffordshire
    British95294050001
    TRICKEY, Philip John
    Ludshott House Seymour Road
    Headley Down
    GU35 8JX Bordon
    Hampshire
    Amministratore
    Ludshott House Seymour Road
    Headley Down
    GU35 8JX Bordon
    Hampshire
    EnglandBritish72857220001
    WILLIAMS, Richard John
    257 Sheen Lane
    SW14 8RN London
    Amministratore
    257 Sheen Lane
    SW14 8RN London
    British64882280001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    TRIBAL NC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of rent deposit
    Creato il 05 set 2007
    Consegnato il 11 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The interest bearing sterling deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Laminglade Limited and Laminpark Limited
    Transazioni
    • 11 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture
    Creato il 17 set 2004
    Consegnato il 30 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 30 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 feb 2004
    Consegnato il 24 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hg Investment Managers Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 24 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 dic 2002
    Consegnato il 18 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rowan Nominees Limited
    Transazioni
    • 18 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 giu 2002
    Consegnato il 02 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All other goodwill in the UK and elsewhere worldwide and the unregistered trade marks and trade names,the core software and the architecture software. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 02 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 mag 2001
    Consegnato il 19 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the beneficiaries under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the financial accommodation from time to time granted
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 19 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 13 set 2000
    Consegnato il 22 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re agora healthcare services limited barclays high interest business account number 30648299. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 set 2000
    Consegnato il 14 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the financial accommodation under the terms of this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 14 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0