TRIBAL NC LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TRIBAL NC LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03442665 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TRIBAL NC LIMITED?
- Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova TRIBAL NC LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Kings Orchard Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TRIBAL NC LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| NEWCHURCH LIMITED | 04 ott 2000 | 04 ott 2000 |
| AGORA HEALTHCARE SERVICES LIMITED | 01 ott 1997 | 01 ott 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TRIBAL NC LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TRIBAL NC LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per TRIBAL NC LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Stato del capitale al 28 gen 2016
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Robert Charles Garner come amministratore in data 01 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Keith Martin Evans come amministratore in data 30 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Derrick Breach il 05 giu 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR a Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ in data 04 ago 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 87-91 Newman Street London W1T 3EY* in data 09 mar 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Lorraine Davis come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed newchurch LIMITED\certificate issued on 24/05/11 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||||||
Nomina di Dr Keith Martin Evans come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TRIBAL NC LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREACH, Stephen Derrick | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 174695940001 | |||||
| GARNER, Robert Charles | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard | United Kingdom | British | 53391420003 | |||||
| ANDO, Daniella | Segretario | 30 Concord Court Winery Lane KT1 3GF Kingston Upon Thames Surrey | British | 51693570001 | ||||||
| COLLINS, Richard Hawke | Segretario | Newman Street W1T 3EY London 87-91 | British | 136546790001 | ||||||
| DAVIS, Lorraine Anne | Segretario | Newman Street W1T 3EY London 87-91 | 150939960001 | |||||||
| GAMBER, Mark Francis | Segretario | Erskine Cottage Garden Close Givons Grove KT22 8LU Leatherhead 10 Surrey | British | 51105690002 | ||||||
| HARMES, David Orlando Spencer | Segretario | 10 Lime Walk SL6 6QB Maidenhead Berkshire | British | 60400060001 | ||||||
| HERCUS, Ivan Lindsay | Segretario | 6 Beaumont Crescent W14 9LX London | British | 116757120001 | ||||||
| MANNING, Kingsley Guy | Segretario | 6 Gatcombe Road Tufnell Park N19 4PT London | British | 15931310001 | ||||||
| MANNING, Kingsley Guy | Segretario | 6 Gatcombe Road Tufnell Park N19 4PT London | British | 15931310001 | ||||||
| WARNER, Evelyn Patricia | Segretario | Robin Hill Drive GU15 1EG Camberley 23 Surrey United Kingdom | British | 129486480001 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| CONAGHAN, John Edward, Mr. | Amministratore | 11 Danegeld Place PE9 2AF Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | 97327390002 | |||||
| DEWEY, Kevin | Amministratore | Oak Tree Cottage 18 Meadway KT10 9HF Esher Surrey | British | 6631200001 | ||||||
| EVANS, Keith Martin, Dr | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | United Kingdom | British | 159812510001 | |||||
| FIELD, Andrew | Amministratore | Newman Street W1T 3EY London 87-91 | England | British | 61471170001 | |||||
| GAMBER, Mark Francis | Amministratore | Erskine Cottage Garden Close Givons Grove KT22 8LU Leatherhead 10 Surrey | British | 51105690002 | ||||||
| GODBER, Stephen Alison | Amministratore | 41-51 Brighton Road RH1 6YS Redhill Surrey | United Kingdom | British | 105071600001 | |||||
| HARMES, David Orlando Spencer | Amministratore | 10 Lime Walk SL6 6QB Maidenhead Berkshire | England | British | 60400060001 | |||||
| HINE, Duncan, Dr | Amministratore | Glenrue 6 Butt Lane Close LE10 1LF Hinckley Leicestershire | British | 13396990001 | ||||||
| KANTER, Ralph Thomas Ludwig | Amministratore | Garden Flat 17 Upper Park Road NW3 2UN London | United Kingdom | British | 124153720001 | |||||
| KEY, Simon Robert | Amministratore | 4 Old Street SP4 8JT Salisbury Wiltshire | England | British | 41514390002 | |||||
| KHAN, Junaid | Amministratore | 33 The Ridings KT11 2PU Cobham Surrey | British | 98917630001 | ||||||
| LAMBERT, Susan | Amministratore | 20 Pinel Close Virginia Park GU25 4SP Virginia Water Surrey | British | 113974450001 | ||||||
| LAWTON, Simon Marcus | Amministratore | Newman Street W1T 3EY London 87-91 | England | British | 68807890004 | |||||
| MANNING, Kingsley Guy | Amministratore | 22a Jacobs Well Mews W1U 3DR London | United Kingdom | British | 15931310003 | |||||
| MARTIN, Nicholas Rupert Zelenka | Amministratore | 123 Mallinson Road SW11 1BH London | British | 23175310002 | ||||||
| MARTIN, Peter John | Amministratore | Newman Street W1T 3EY London 87-91 | England | British | 176044430001 | |||||
| SALLIS, David | Amministratore | 42 Sheen Park TW9 1UW Richmond Surrey | United Kingdom | Uk | 44780590002 | |||||
| SETCHELL, Brenda Carol | Amministratore | Newman Street W1T 3EY London 87-91 | United Kingdom | British | 90477860001 | |||||
| STONE, Lisa Jane | Amministratore | The Grange Sandhill Lane, Crawley Down RH10 4LB Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 69455810002 | |||||
| TOLLEY, Robyn William | Amministratore | The Old Barn Blithbury WS15 3JG Rugeley Staffordshire | British | 95294050001 | ||||||
| TRICKEY, Philip John | Amministratore | Ludshott House Seymour Road Headley Down GU35 8JX Bordon Hampshire | England | British | 72857220001 | |||||
| WILLIAMS, Richard John | Amministratore | 257 Sheen Lane SW14 8RN London | British | 64882280001 | ||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
TRIBAL NC LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of rent deposit | Creato il 05 set 2007 Consegnato il 11 set 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The interest bearing sterling deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| All assets debenture | Creato il 17 set 2004 Consegnato il 30 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 13 feb 2004 Consegnato il 24 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 13 dic 2002 Consegnato il 18 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 giu 2002 Consegnato il 02 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All other goodwill in the UK and elsewhere worldwide and the unregistered trade marks and trade names,the core software and the architecture software. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 mag 2001 Consegnato il 19 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys,obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the beneficiaries under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the financial accommodation from time to time granted | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 13 set 2000 Consegnato il 22 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Barclays bank PLC re agora healthcare services limited barclays high interest business account number 30648299. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 set 2000 Consegnato il 14 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the financial accommodation under the terms of this debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0