DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED

DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03444409
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No. 1 Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 lug 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 13 lug 2021

    • Capitale: GBP 56,341,654
    4 pagineSH01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Neeraj Kapur come amministratore in data 01 apr 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon George Thomas come amministratore in data 31 mar 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Charles Fisher come amministratore in data 03 dic 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Simon George Thomas come amministratore in data 03 dic 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr David George Whincup come segretario in data 16 lug 2018

    2 pagineAP03

    legacy

    pagineANNOTATION

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Paula Watts come segretario in data 31 mar 2018

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHINCUP, David George
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    Segretario
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    249464050001
    KAPUR, Neeraj
    No. 1 Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    Provident Financial Plc
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    No. 1 Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    Provident Financial Plc
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish268623050001
    LE MAY, Malcolm John
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish43422720003
    MARSHALL SMITH, Rosamond Joy
    Colonnade
    Sunbridge Road
    BD1 2LQ Bradford
    West Yorkshire
    Segretario
    Colonnade
    Sunbridge Road
    BD1 2LQ Bradford
    West Yorkshire
    British17986770001
    MEYRICK, Stephen John
    16 Delanly Court
    Wimblehurst Road
    RG12 2DU Horsham
    West Sussex
    Segretario
    16 Delanly Court
    Wimblehurst Road
    RG12 2DU Horsham
    West Sussex
    British106205110001
    NEWBY, Leonard John
    Scheveningen Huis
    Ashdown Road
    RH18 5BN Forest Row
    East Sussex
    Segretario
    Scheveningen Huis
    Ashdown Road
    RH18 5BN Forest Row
    East Sussex
    British55084420001
    VERSLUYS, Emma Gayle
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    British102724740003
    WATTS, Paula
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    Segretario
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    232277070001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Segretario nominato
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    COOPER, Julian Edward Peregrine
    17b Sheridan Road
    Merton Park
    SW19 3HW London
    Amministratore
    17b Sheridan Road
    Merton Park
    SW19 3HW London
    United KingdomBritish91049680001
    CROOK, Peter Stuart
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish109187730001
    DUNKLEY, Paul John
    Stoke Gap House
    Ashton Road Stoke Bruerne
    NN12 7SL Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    Stoke Gap House
    Ashton Road Stoke Bruerne
    NN12 7SL Towcester
    Northamptonshire
    EnglandBritish34398930002
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    17 Holt Avenue
    Adel
    LS16 8DH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Holt Avenue
    Adel
    LS16 8DH Leeds
    West Yorkshire
    British77093570001
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    17 Holt Avenue
    Adel
    LS16 8DH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Holt Avenue
    Adel
    LS16 8DH Leeds
    West Yorkshire
    British77093570001
    FISHER, Andrew Charles
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish41331580002
    GLEN, Robert John
    5 High Meadows
    Firth Lane Wilsden
    BD15 0HN Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 High Meadows
    Firth Lane Wilsden
    BD15 0HN Bradford
    West Yorkshire
    EnglandUnited Kingdom87214920001
    HARRISON, Richard
    97 Orchard Grove
    Chalfont St Peter
    SL9 9ET Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    97 Orchard Grove
    Chalfont St Peter
    SL9 9ET Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British100892740002
    JOHNSTONE, Christopher Charles
    Pine Lodge
    Castle Lane Ripponden
    HX6 4JZ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pine Lodge
    Castle Lane Ripponden
    HX6 4JZ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    British53747580002
    LINDSEY, Ian Walter
    3 Kinderscout
    HP3 8HW Leverstock Green
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Kinderscout
    HP3 8HW Leverstock Green
    Hertfordshire
    United KingdomBritish85980860001
    MACLEOD, Gregory Ian
    Murrayfield
    13 Windsor Road
    SL9 7NB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Murrayfield
    13 Windsor Road
    SL9 7NB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomAustralian60518160005
    MARSHALL SMITH, Rosamond Joy
    Colonnade
    Sunbridge Road
    BD1 2LQ Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Colonnade
    Sunbridge Road
    BD1 2LQ Bradford
    West Yorkshire
    British17986770001
    MEYRICK, Stephen John
    16 Delanly Court
    Wimblehurst Road
    RG12 2DU Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    16 Delanly Court
    Wimblehurst Road
    RG12 2DU Horsham
    West Sussex
    British106205110001
    NEWBY, Anthony Charles
    Millhouse
    Church Road, Woolton
    L25 6DA Liverpool
    Amministratore
    Millhouse
    Church Road, Woolton
    L25 6DA Liverpool
    British54172180002
    NEWBY, Anthony
    51 Wheatcroft Road
    Allerton
    L18 9UF Liverpool
    Amministratore
    51 Wheatcroft Road
    Allerton
    L18 9UF Liverpool
    British54172180001
    NEWBY, Leonard John
    Scheveningen Huis
    Ashdown Road
    RH18 5BN Forest Row
    East Sussex
    Amministratore
    Scheveningen Huis
    Ashdown Road
    RH18 5BN Forest Row
    East Sussex
    British55084420001
    PARSONAGE, Robert David
    Homeleigh
    10 Chart Way
    RH2 0NZ Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Homeleigh
    10 Chart Way
    RH2 0NZ Reigate
    Surrey
    British108363060001
    PLOWMAN, Stephen Russell
    Drummers Yard
    Sproutes Lane, Coolham
    RH13 8QH Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Drummers Yard
    Sproutes Lane, Coolham
    RH13 8QH Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish76672190002
    PLOWMAN, Stephen Russell
    Drummers Yard
    Sproutes Lane, Coolham
    RH13 8QH Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Drummers Yard
    Sproutes Lane, Coolham
    RH13 8QH Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish76672190002
    PRINCE, Joseph Michael
    Keffolds
    44 Tongdean Avenue
    BN3 6TN Hove
    East Sussex
    Amministratore
    Keffolds
    44 Tongdean Avenue
    BN3 6TN Hove
    East Sussex
    British71867540003
    PRINCE, Joseph Michael
    Meadowside
    Piltdown
    TN22 3XD Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Meadowside
    Piltdown
    TN22 3XD Uckfield
    East Sussex
    British71867540001
    SHAW, Simon Andrew
    Horrocks Close
    BD20 8HQ Lothersdale
    North Yorkshire
    Amministratore
    Horrocks Close
    BD20 8HQ Lothersdale
    North Yorkshire
    UkBritish87062650001
    THOMAS, Simon George
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    Amministratore
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No. 1
    West Yorkshire
    EnglandBritish253188120001
    THORNTON, John Rolfe
    Kirk Lea
    Main Street
    HG5 9LD Staveley
    North Yorkshire
    Amministratore
    Kirk Lea
    Main Street
    HG5 9LD Staveley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish147555560001
    WEBSTER, James Maxwell
    28d Cruden Street
    N1 8NH London
    Amministratore
    28d Cruden Street
    N1 8NH London
    United KingdomBritish97036540001
    YATES, Stuart William
    81 Gunterstone Road
    West Kensington
    W14 9BT London
    Amministratore
    81 Gunterstone Road
    West Kensington
    W14 9BT London
    EnglandBritish108370390001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No 1 Godwin Street
    England
    06 apr 2016
    Godwin Street
    BD1 2SU Bradford
    No 1 Godwin Street
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione668987
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed of charge
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 19 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title interest and benefit of the company in and to the scottish funded receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Spartacus One, Inc
    Transazioni
    • 19 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed of charge
    Creato il 09 mar 2001
    Consegnato il 28 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or any other transaction document (as defined)
    Brevi particolari
    All right title interest and benefit in and to the scottish funded receivables to the extent not previously assigned in favour of the chargee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Spartacus One, Inc.
    Transazioni
    • 28 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Scottish trust security
    Creato il 08 mar 2001
    Consegnato il 28 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the debenture, the facility agreement, the transaction documents and such other documents (if any) as may constitute or evidence any of the secured obligations.
    Brevi particolari
    The funded receivables governed by scots law forming part of the funded receivables and all amounts becoming payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Spartacus One, Inc.
    Transazioni
    • 28 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2001
    Consegnato il 28 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or any other transaction document (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Spartacus One, Inc.
    Transazioni
    • 28 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    First supplemental deed to composite guarantee and debenture dated 26 july 1999
    Creato il 08 mar 2001
    Consegnato il 27 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 26 july 1999, a composite guarantee and debenture dated 26 july 1999, a facility agreement dated 26 july 1999, an inter-creditor agreement dated 26 july 1999, a subordination deed 26 july 1999 and the first supplemental deed and any and all other mortgages, charges, guarantees and other instruments from time to time entered into by the parent and/or both/either of the borrowers by way of guarantee or other assurance of and/or security for amounts owed to the bank under the facility agreement
    Brevi particolari
    The debenture charges all the present and future assets of the company. First fixed charges over all of the present and future assets of the company of the following types (a) land, interests in land and fixtures (b) plant, machinery and equipment (c) shares, bonds and other securities of any kind (d) debts and claims (e) the proceeds of collection of debts and claims and credit balances at banks (f) the benefit of insurances (g) goodwill and uncalled capital (h) intellectual property of all kinds in each case, together with all associated rights (the fixed charge). Excluded from the fixed charge are all of the undertakings, assets, interests, rights and benefits of the company which are charged by way of fixed charge in favour of spartacus one, incorporated pursuant to a debenture dated 8 march 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC on Behalf of Itself and and the Banks Fromtime to Time Parties to the Facility Agreement
    Transazioni
    • 27 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 lug 1999
    Consegnato il 30 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other company to the chargee on behalf of itself and the banks from time to time parties to the facility agreement under or pursuant to the secured documents (as defined) and all monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents and by any other present or future subsidiary of the parent or of any company and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 16 dic 1997
    Consegnato il 30 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents (as defined) and all monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents and by any other present or future subsidiary of the parent or of any company
    Brevi particolari
    K/A unit 2 monckton road industrial estate denby dale road, wakefield t/no: WYK592491 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DIRECT AUTO FINANCIAL SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 lug 2021Inizio della liquidazione
    06 lug 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0