GOOD INFLUENCE LIMITED
Panoramica
Nome della società | GOOD INFLUENCE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03449094 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GOOD INFLUENCE LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova GOOD INFLUENCE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | PO BOX 70693 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GOOD INFLUENCE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
1B COMMUNICATIONS LIMITED | 22 giu 2012 | 22 giu 2012 |
DE FACTO COMMUNICATIONS LIMITED | 30 mar 2005 | 30 mar 2005 |
DE FACTO COMMUNICATIONS PLC | 30 lug 2003 | 30 lug 2003 |
H.C.C. DE FACTO GROUP PLC | 08 ott 1997 | 08 ott 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GOOD INFLUENCE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per GOOD INFLUENCE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 3 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 3 pagine | MR04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ott 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 10 pagine | AAMD | ||||||||||
legacy | 80 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David Crowther come amministratore in data 31 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Fiona Mary Sharp come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Fiona Mary Sharp il 01 ott 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di un segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Edward Davison come segretario in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Edward Davison come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 ott 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da PO Box 70693 Southside 105 Victoria Street London SW1P 9ZP a PO Box 70693 62 Buckingham Gate London SW1P 9ZP in data 18 feb 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di GOOD INFLUENCE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROWTHER, David | Amministratore | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance | 184391050001 | ||||
CHARLES, Susan Jane | Segretario | Ollatrim 34 Woodfield Hill CR5 3EP Coulsdon Surrey | British | Communications Consultant | 40366110001 | |||||
CONINGTON, Mary Denise | Segretario | 17 Rythe Road Claygate KT10 9DG Esher Surrey | British | 39416550001 | ||||||
DAVISON, Robert Edward | Segretario | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | British | 175283600001 | ||||||
DAVISON, Robert Edward | Segretario | Yeomans Close Thorley Park CM23 4EU Bishops Stortford 23 Hertfordshire | British | 45449440002 | ||||||
DWYER, Daniel John | Segretario nominato | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
EVERITT, David Anthony | Segretario | Shorncliffe Lodge Undercliff CT20 3AT Sandgate Kent | British | 33752810001 | ||||||
TOLLISS, Thomas George | Segretario | Curzon Street W1J 5HN London 14 United Kingdom | British | 165540160001 | ||||||
ANDERSON, Richard James | Amministratore | The White Cottage 4 Thornton Road SW19 4NB Wimbledon | British | Advertising Executive | 39416370003 | |||||
CHAPMAN, Simon Charles, Dr | Amministratore | 15 Westminster Gardens SW1P 4JA London | British | Marketing Consultant | 119295110001 | |||||
CHARLES, Susan Jane | Amministratore | Ollatrim 34 Woodfield Hill CR5 3EP Coulsdon Surrey | British | Communications Consultant | 40366110001 | |||||
CONINGTON, Paul Edward Martin | Amministratore | 17 Rythe Road Claygate KT10 9DG Esher Surrey | United Kingdom | British | Executive | 141476280002 | ||||
DAVISON, Robert Edward | Amministratore | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | United Kingdom | British | Group Secretary | 45449440002 | ||||
DIBLE, David James | Amministratore | Church House 118 Trinity Road EH5 3LA Edinburgh Midlothian | British | Director | 72447220001 | |||||
DOYLE, Betty June | Amministratore delegato nominato | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
DWYER, Daniel John | Amministratore delegato nominato | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
EVERITT, David Anthony | Amministratore | Shorncliffe Lodge Undercliff CT20 3AT Sandgate Kent | British | Chartered Accountant | 33752810001 | |||||
HAYHURST, Richard Frank | Amministratore | 19 Riverdale Gardens TW1 2BX East Twickenham Middlesex | British | Executive | 15866330003 | |||||
KIDDY, Christine Susan | Amministratore | 2 Regents Gate Sarisbury Green SO31 7LB Southampton Hampshire | British | Executive | 86197080001 | |||||
LEECE, John Henry | Amministratore | 12 Mayfield Road Wimbledon SW19 3NF London | United Kingdom | British | Finance Director | 10904170002 | ||||
MAHON, Michaela | Amministratore | 2 Righton Close Charvil RG10 9UN Twyford Berkshire | British | Pr Consultant | 79001260001 | |||||
PAYNE, Kevin Jacques | Amministratore | Culmer Corner Culmer Lane GU8 5SP Wormley Surrey | British | Executive | 40366170001 | |||||
SANDEMAN, Diane Elizabeth | Amministratore | 17 Ravel Close Brighton Hill RG22 4EB Basingstoke Hampshire | British | Executive | 48719120001 | |||||
SHARP, Fiona Mary | Amministratore | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 66457680002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GOOD INFLUENCE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chime Communications Limited | 06 apr 2016 | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
GOOD INFLUENCE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 22 ago 2012 Consegnato il 29 ago 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 31 mar 2006 Consegnato il 07 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 06 giu 2002 Consegnato il 11 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company with full title guarantee charges £16,000.00 to the chargee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 26 gen 2001 Consegnato il 30 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the rent deposit deed | |
Brevi particolari £16,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 gen 1999 Consegnato il 02 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 19 giu 1998 Consegnato il 23 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined within | |
Brevi particolari The initial deposit of £41,750 and all other monies relative thereto ( the "deposit balance"). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0