COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED
Panoramica
Nome della società | COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03449629 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TALKMAJOR LIMITED | 14 ott 1997 | 14 ott 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 22 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP in data 23 ott 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 15 dic 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Catchpole come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Jon William Mortimore come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Fitzsimmons il 01 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSEY, Joanne Elizabeth | Segretario | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147808280001 | |||||||
LEWIS, Colin Edward | Amministratore | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Wales | British | Director | 59395180001 | ||||
SHARP, Giles Henry | Amministratore | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 194659450001 | ||||
GANDHI, Devendra | Segretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | Director | 75350600002 | |||||
JOHNSON, Robin Simon | Segretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
MALDE, Nishith | Segretario | Tudor House 69 Camlet Way EN4 0NL Hadley Wood Hertfordshire | British | Accountant | 148459300001 | |||||
YULL, Peter Raymond | Segretario | Foxend Nugents Park Hatch End HA5 4RA Pinner Middlesex | British | 12500120001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BEAZER, Anthony Hadyn | Amministratore | 172b West Hill Putney SW15 3SL London | United Kingdom | British | Director | 91412650001 | ||||
BROWN, Carole Elizabeth | Amministratore | 11 Yelvertoft Road Crick NN6 7TR Northampton Barn 1 | England | British | Secretary | 98235420004 | ||||
CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Amministratore | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | Director | 154997530001 | ||||
DIPRE, John Vivian | Amministratore | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 9018280015 | ||||
DIPRE, Remo | Amministratore | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | Director | 35117250001 | ||||
FITZSIMMONS, Neil | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 69006050003 | ||||
FOLBIGG, Malcolm Dennis Geoffrey | Amministratore | 14 Duck End Lane Maulden MK45 2DL Bedford Bedfordshire | British | Director | 56367690001 | |||||
FOSTER, David Martin | Amministratore | Bear Park 31 Nightingale Road WD3 7DA Rickmansworth Hertfordshire | England | British | Director | 50285750005 | ||||
GAFFNEY, David | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | Director | 84605410002 | ||||
GANDHI, Devendra | Amministratore | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | Director | 75350600002 | ||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Cro | 137285750001 | ||||
MALDE, Nishith | Amministratore | Tudor House 69 Camlet Way EN4 0NL Hadley Wood Hertfordshire | England | British | Accountant | 148459300001 | ||||
MORTIMORE, Jon William | Amministratore | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent | United Kingdom | British | Cfo | 207729000002 | ||||
WICKS, Stephen Desmond | Amministratore | Sherwood House Oxhey Drive HA6 3EU Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Director Proposed | 42298130002 | ||||
YULL, Peter Raymond | Amministratore | Foxend Nugents Park Hatch End HA5 4RA Pinner Middlesex | British | Chartered Surveyor | 12500120001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 30 dic 2008 Consegnato il 09 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 28 apr 2005 Consegnato il 11 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment and charge | Creato il 30 mag 2000 Consegnato il 03 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The company's interest in an agreement of 30/5/00. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 30 mag 2000 Consegnato il 03 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at royal earlswood park redhill surrey and the proceeds of sale thereof and any insurance policy proceeds thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 30 mag 2000 Consegnato il 03 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at royal earlswood park redhill surrey. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 feb 2000 Consegnato il 11 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A floating charge over the undertaking property and assets present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Equitable charge | Creato il 22 ott 1998 Consegnato il 28 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and metropolitan homes PLC to the chargee on any account whatsoever but not exceeding £1,600,000 | |
Brevi particolari All rights title benefit and interest in the agreement dated 9/10/98 and in the property or in the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 22 ott 1998 Consegnato il 28 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Part of the former royal earlswood hospital redhill surrey forming part of the land under t/n SY679246. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 22 ott 1998 Consegnato il 28 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 01 lug 1998 Consegnato il 10 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £942,272 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreements | |
Brevi particolari All the company's interest at royal earlswood hospital redhill surrey together with proceeds of sale thereof proceeds of insurance rental and other monies in connection with the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0