COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED

COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03449629
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TALKMAJOR LIMITED14 ott 199714 ott 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP in data 23 ott 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ott 2015

    Stato del capitale al 14 ott 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 15 dic 2014

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ott 2014

    Stato del capitale al 14 ott 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Elizabeth Catchpole come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Jon William Mortimore come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ott 2013

    Stato del capitale al 14 ott 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Fitzsimmons il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Segretario
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808280001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Segretario
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    BritishAccountant148459300001
    YULL, Peter Raymond
    Foxend Nugents Park
    Hatch End
    HA5 4RA Pinner
    Middlesex
    Segretario
    Foxend Nugents Park
    Hatch End
    HA5 4RA Pinner
    Middlesex
    British12500120001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Amministratore
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritishDirector91412650001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    Amministratore
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    EnglandBritishSecretary98235420004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154997530001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    FOLBIGG, Malcolm Dennis Geoffrey
    14 Duck End Lane
    Maulden
    MK45 2DL Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    14 Duck End Lane
    Maulden
    MK45 2DL Bedford
    Bedfordshire
    BritishDirector56367690001
    FOSTER, David Martin
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector50285750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant148459300001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United KingdomBritishCfo207729000002
    WICKS, Stephen Desmond
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector Proposed42298130002
    YULL, Peter Raymond
    Foxend Nugents Park
    Hatch End
    HA5 4RA Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    Foxend Nugents Park
    Hatch End
    HA5 4RA Pinner
    Middlesex
    BritishChartered Surveyor12500120001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (EARLSWOOD) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 09 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment and charge
    Creato il 30 mag 2000
    Consegnato il 03 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company's interest in an agreement of 30/5/00.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 mag 2000
    Consegnato il 03 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at royal earlswood park redhill surrey and the proceeds of sale thereof and any insurance policy proceeds thereon.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mag 2000
    Consegnato il 03 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at royal earlswood park redhill surrey. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 feb 2000
    Consegnato il 11 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A floating charge over the undertaking property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable charge
    Creato il 22 ott 1998
    Consegnato il 28 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and metropolitan homes PLC to the chargee on any account whatsoever but not exceeding £1,600,000
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest in the agreement dated 9/10/98 and in the property or in the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dependable Properties Limited
    Transazioni
    • 28 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 ott 1998
    Consegnato il 28 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part of the former royal earlswood hospital redhill surrey forming part of the land under t/n SY679246. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dependable Properties Limited
    Transazioni
    • 28 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 ott 1998
    Consegnato il 28 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Dependable Properties Limited
    Transazioni
    • 28 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 lug 1998
    Consegnato il 10 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £942,272 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreements
    Brevi particolari
    All the company's interest at royal earlswood hospital redhill surrey together with proceeds of sale thereof proceeds of insurance rental and other monies in connection with the property.
    Persone aventi diritto
    • Barratt Homes Limited
    Transazioni
    • 10 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0