CAPARO ENGINEERING LIMITED

CAPARO ENGINEERING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAPARO ENGINEERING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03450375
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    • fusione di ghisa (24510) / Industrie manifatturiere
    • fusione di altri metalli non ferrosi (24540) / Industrie manifatturiere
    • fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. (25990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Floor 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SUPREMO 2000 LIMITED15 ott 199715 ott 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    23 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2023

    23 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2022

    22 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:secreatary of state release of liquidator.
    1 pagineLIQ MISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2021

    23 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    15 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    13 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2020

    24 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2019

    25 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    4 pagineLIQ MISC

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    17 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    34 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    32 pagineAM10

    Indirizzo della sede legale modificato da 7 More London Riverside London SE1 2RT a Floor 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds Yorkshire LS1 4DL in data 07 ott 2017

    2 pagineAD01

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    29 pagineAM10

    Dimissioni di un amministratore

    11 pagine2.38B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 ott 2016

    27 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Risultato della riunione dei creditori

    1 pagine2.23B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 apr 2016

    32 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Derek Michael O'reilly come amministratore in data 17 dic 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PAUL, Angad, The Honorable
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    Amministratore
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    United KingdomUnited Kingdom130813310001
    BENNETT, Paul Richard
    1 Ennerdale Drive
    B63 1HL Halesowen
    West Midlands
    Segretario
    1 Ennerdale Drive
    B63 1HL Halesowen
    West Midlands
    British76951010001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Segretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    British126516810001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    BEATON, Kevin
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritish150211630001
    BOTTING, Richard Graham
    7 Bromwich Drive
    WS13 8SD Fradley
    Staffordshire
    Amministratore
    7 Bromwich Drive
    WS13 8SD Fradley
    Staffordshire
    British85897150001
    BUTLER, Richard Gareth John
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish117859680001
    CLIFF, Richard Martyn
    Waterside House
    Church Street Wyre Piddle
    WR10 2JD Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Waterside House
    Church Street Wyre Piddle
    WR10 2JD Pershore
    Worcestershire
    United KingdomBritish56113440001
    CURRAN, James Thomas
    The Old Post Office
    10 Hill View Road Strensham
    WR8 9LJ Worcester
    Amministratore
    The Old Post Office
    10 Hill View Road Strensham
    WR8 9LJ Worcester
    United KingdomBritish56844020001
    DANCASTER, David Patrick
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    Amministratore
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    EnglandBritish55380530001
    GANE, Christopher Nigel
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    ScotlandBritish73268030001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HAMMOND, Christopher Mark
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritish60992860002
    HARTLAND, Melvyn Edward
    7 Merriemont Drive
    Barnt Green
    B45 8QZ Birmingham
    Amministratore
    7 Merriemont Drive
    Barnt Green
    B45 8QZ Birmingham
    British8436920002
    O'REILLY, Derek Michael
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritish108440160002
    PAUL, Akhil
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish199010800001
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritish92729600003
    PAY, Jason Christopher
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish126516810001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish126516810001
    PINCHES, Brian Michael
    2 Berkeley Close
    Perton
    WV6 7RX Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    2 Berkeley Close
    Perton
    WV6 7RX Wolverhampton
    West Midlands
    British44065140001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish56051330001
    TAYLOR, Paul
    86 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SL Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    86 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SL Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish49786260004
    UNDERHILL, Maurice
    339 Birmingham Road
    WS5 3NU Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    339 Birmingham Road
    WS5 3NU Walsall
    West Midlands
    British12842580001
    WHALE, Ian
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish192902390001
    WOOD, John Franklin
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Amministratore
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish1397720001
    WOOD, John Franklin
    27 Oak Hill Drive
    Edgbaston
    B15 3UG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    27 Oak Hill Drive
    Edgbaston
    B15 3UG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish1397720001

    CAPARO ENGINEERING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 feb 2014
    Consegnato il 13 mar 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Caparo PLC
    Transazioni
    • 13 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 15 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H property. Caparo testing, brenda road, hartlepool t/no CE52039.. Caparo forgoing, marriott road, dudley t/no WM383778. (For details of patents charged please refer to form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited
    Transazioni
    • 15 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 05 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H land at caparo testing brenda road hartlepool t/no CE52039. F/h land at caparo forging marriott road dudley t/no WM383778. Patent described as "mounting (cmt own shock absorber)" filed in 1998 with number GB2330642. For details of further intellectual property please refer to deed. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 05 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Polish law registered pledge agreement
    Creato il 19 ago 2011
    Consegnato il 25 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of pln 50,000,000 (say: fifty million zlotys), all the rights. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Caparo PLC
    Transazioni
    • 25 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Polish law registered pledge agreement
    Creato il 19 ago 2011
    Consegnato il 25 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of eur 10,000,000 (say: ten million euro), all the rights. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jalia Holding S.A.
    Transazioni
    • 25 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Pledge agreement
    Creato il 30 nov 2010
    Consegnato il 10 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of pln 50,000,000.
    Persone aventi diritto
    • Caparo PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Pledge agreement
    Creato il 26 nov 2010
    Consegnato il 10 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of eur 10,000,000.
    Persone aventi diritto
    • Jalia Holding Sa
    Transazioni
    • 10 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security agreement
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    Creato il 31 gen 2002
    Consegnato il 14 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (I) fixed equitable charge any debt (as defined in the agreement) purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement including its related rights (purchased debts) both present and future which fail to vest absolutely and effectively in the chargee for any reason and (ii) fixed equitable charge all amounts of indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever including the related rights, other than any purchased debt (other debts) and (iii) floating charge such monies the company may receive in respect of the other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    CAPARO ENGINEERING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 ott 2015Inizio dell'amministrazione
    26 ott 2018Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    2
    DataTipo
    26 ott 2018Inizio della liquidazione
    21 mag 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Edward Williams
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0