GATEWAY OFFSITE LTD
Panoramica
| Nome della società | GATEWAY OFFSITE LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03453040 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GATEWAY OFFSITE LTD?
- (7499) /
Dove si trova GATEWAY OFFSITE LTD?
| Indirizzo della sede legale | Unicorn House Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough East Yorkshire United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GATEWAY OFFSITE LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BRITSPACE HOTELS LIMITED | 09 dic 2008 | 09 dic 2008 |
| GATEWAY FABRICATIONS LIMITED | 29 dic 1997 | 29 dic 1997 |
| TALKTOP LIMITED | 21 ott 1997 | 21 ott 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GATEWAY OFFSITE LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per GATEWAY OFFSITE LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Cowan come segretario in data 30 set 2011 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Sherriff come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Matthew Cowan come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Second Floor 77 Kingsway London WC2B 6SR United Kingdom in data 28 giu 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unicorn House Broad Lane Gilberdyke Brough East Yorkshire HU15 2TS in data 27 giu 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Bradney come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Christopher Harris come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Terence Jackson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di James Bradney come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Christopher John Huckle come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Ian Sherriff come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Clarke come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 12 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 11 pagine | MG01 | ||||||||||
legacy | 5 pagine | MG01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GATEWAY OFFSITE LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS, David Christopher | Amministratore | Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough Unicorn House East Yorkshire United Kingdom | England | British | 76088090001 | |||||
| HUCKLE, Christopher John | Amministratore | Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough Unicorn House East Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141831160001 | |||||
| BALL, Martin John | Segretario | Sandwood House Ashfield LE15 6QB Oakham Rutland | British | 63261140001 | ||||||
| CLARKE, Stephen | Segretario | Unicorn House Broad Lane HU15 2TS Gilberdyke Brough East Yorkshire | British | 122285190001 | ||||||
| COWAN, Matthew | Segretario | Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough Unicorn House East Yorkshire United Kingdom | 161230490001 | |||||||
| FARMERY, Michael David | Segretario | 26 Crawshaw Avenue HU17 7QW Beverley East Yorkshire | British | 19792670001 | ||||||
| HORNCASTLE, Carole Diane | Segretario | Beech Hill House Beech Hill Road, Swanland HU14 3QY North Ferriby East Yorkshire | British | 79178970001 | ||||||
| MCCANN, Leah | Segretario | Flat 2 Merchants Warehouse Robinson Row HU1 2QX Hull East Yorkshire | British | 51908280001 | ||||||
| NEWTON, Christopher John Landsborough | Segretario | The Old Brewery Main Street YO61 2NS Helperby North Yorkshire | British | 101779200001 | ||||||
| SHERRIFF, Ian | Segretario | High Street Barmby-On-The-Marsh DN14 7HS Goole Grey Dene North Humberside United Kingdom | 149407420001 | |||||||
| WHITE, Norman | Segretario | 19 Burnby Lane Pocklington YO42 2QB York North Yorkshire | British | 29472760001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ATKINSON, Stewart Martin | Amministratore | Springwell 32 Bondend Road Upton St Leonards GL4 8DY Gloucester Gloucestershire | England | British | 100469640001 | |||||
| BALL, Martin John | Amministratore | Sandwood House Ashfield LE15 6QB Oakham Rutland | United Kingdom | British | 63261140001 | |||||
| BALL, Martin John | Amministratore | Sandwood House Ashfield LE15 6QB Oakham Rutland | United Kingdom | British | 63261140001 | |||||
| BEALES, Stuart Patrick | Amministratore | Spring Road Market Weighton YO43 3JE York 28 North Yorkshire | United Kingdom | British | 136886810001 | |||||
| BRADNEY, James | Amministratore | Unicorn House Broad Lane HU15 2TS Gilberdyke Brough East Yorkshire | United Kingdom | British | 161101450001 | |||||
| CLARK, William Angus | Amministratore | Folds Head Close Folds Head, Calver S32 3XJ Hope Valley Derbyshire | British | 80223540001 | ||||||
| FARMERY, Michael David | Amministratore | 26 Crawshaw Avenue HU17 7QW Beverley East Yorkshire | England | British | 19792670001 | |||||
| HARRIS, David Christopher | Amministratore | 35 Carter Drive HU17 9GL Beverley East Yorkshire | England | British | 76088090001 | |||||
| HORNCASTLE, Andrew Nigel | Amministratore | Beech Hill House Beech Hill Road Swanland HU14 3QY North Ferriby North Humberside | England | British | 4456360002 | |||||
| JACKSON, Terence William | Amministratore | Beech Hill Road HU14 3QY Swanland The Hollies 7 East Yorkshire | Uk | British | 132410210001 | |||||
| MCCANN, Leah | Amministratore | Flat 2 Merchants Warehouse Robinson Row HU1 2QX Hull East Yorkshire | British | 51908280001 | ||||||
| NEWTON, Christopher John Landsborough | Amministratore | The Old Brewery Main Street YO61 2NS Helperby North Yorkshire | British | 101779200001 | ||||||
| SCANLAN, Sarah Rebecca | Amministratore | 26 Northfield Avenue Hessle HU13 9DL Hull North Humberside | British | 55408650001 | ||||||
| TAYLOR, Malcolm | Amministratore | 9 Copper Beech Close Dunnington YO19 5PY York North Yorkshire | England | British | 83888440001 | |||||
| TREBBLE, Stephen Paul | Amministratore | The Laurels Main Street DN22 8DT Bothamsall Nottinghamshire | England | British | 76640730001 | |||||
| WHITE, Norman | Amministratore | 19 Burnby Lane Pocklington YO42 2QB York North Yorkshire | British | 29472760001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
GATEWAY OFFSITE LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 16 nov 2009 Consegnato il 20 nov 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 16 nov 2009 Consegnato il 20 nov 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 06 nov 2009 Consegnato il 18 nov 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 ott 2008 Consegnato il 18 ott 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 set 2002 Consegnato il 19 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 12 set 2002 Consegnato il 19 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due or to become due from the company and by any other company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 mar 2000 Consegnato il 17 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 31 mar 2000 Consegnato il 06 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0