GATEWAY OFFSITE LTD

GATEWAY OFFSITE LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGATEWAY OFFSITE LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03453040
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GATEWAY OFFSITE LTD?

    • (7499) /

    Dove si trova GATEWAY OFFSITE LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Unicorn House Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GATEWAY OFFSITE LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRITSPACE HOTELS LIMITED09 dic 200809 dic 2008
    GATEWAY FABRICATIONS LIMITED29 dic 199729 dic 1997
    TALKTOP LIMITED21 ott 199721 ott 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di GATEWAY OFFSITE LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per GATEWAY OFFSITE LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Matthew Cowan come segretario in data 30 set 2011

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Ian Sherriff come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Matthew Cowan come segretario

    1 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da Second Floor 77 Kingsway London WC2B 6SR United Kingdom in data 28 giu 2011

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unicorn House Broad Lane Gilberdyke Brough East Yorkshire HU15 2TS in data 27 giu 2011

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di James Bradney come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Christopher Harris come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Terence Jackson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di James Bradney come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Christopher John Huckle come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 21 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ott 2010

    Stato del capitale al 26 ott 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Ian Sherriff come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stephen Clarke come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    12 pagineAA

    legacy

    11 pagineMG01

    legacy

    5 pagineMG01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di GATEWAY OFFSITE LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARRIS, David Christopher
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish76088090001
    HUCKLE, Christopher John
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141831160001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Segretario
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    British63261140001
    CLARKE, Stephen
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    Segretario
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    British122285190001
    COWAN, Matthew
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    161230490001
    FARMERY, Michael David
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    Segretario
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    British19792670001
    HORNCASTLE, Carole Diane
    Beech Hill House
    Beech Hill Road, Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    East Yorkshire
    Segretario
    Beech Hill House
    Beech Hill Road, Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    East Yorkshire
    British79178970001
    MCCANN, Leah
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    Segretario
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    British51908280001
    NEWTON, Christopher John Landsborough
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    Segretario
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    British101779200001
    SHERRIFF, Ian
    High Street
    Barmby-On-The-Marsh
    DN14 7HS Goole
    Grey Dene
    North Humberside
    United Kingdom
    Segretario
    High Street
    Barmby-On-The-Marsh
    DN14 7HS Goole
    Grey Dene
    North Humberside
    United Kingdom
    149407420001
    WHITE, Norman
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    Segretario
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    British29472760001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINSON, Stewart Martin
    Springwell 32 Bondend Road
    Upton St Leonards
    GL4 8DY Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Springwell 32 Bondend Road
    Upton St Leonards
    GL4 8DY Gloucester
    Gloucestershire
    EnglandBritish100469640001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Amministratore
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Amministratore
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BEALES, Stuart Patrick
    Spring Road
    Market Weighton
    YO43 3JE York
    28
    North Yorkshire
    Amministratore
    Spring Road
    Market Weighton
    YO43 3JE York
    28
    North Yorkshire
    United KingdomBritish136886810001
    BRADNEY, James
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish161101450001
    CLARK, William Angus
    Folds Head Close
    Folds Head, Calver
    S32 3XJ Hope Valley
    Derbyshire
    Amministratore
    Folds Head Close
    Folds Head, Calver
    S32 3XJ Hope Valley
    Derbyshire
    British80223540001
    FARMERY, Michael David
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    Amministratore
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    EnglandBritish19792670001
    HARRIS, David Christopher
    35 Carter Drive
    HU17 9GL Beverley
    East Yorkshire
    Amministratore
    35 Carter Drive
    HU17 9GL Beverley
    East Yorkshire
    EnglandBritish76088090001
    HORNCASTLE, Andrew Nigel
    Beech Hill House
    Beech Hill Road Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    North Humberside
    Amministratore
    Beech Hill House
    Beech Hill Road Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritish4456360002
    JACKSON, Terence William
    Beech Hill Road
    HU14 3QY Swanland
    The Hollies 7
    East Yorkshire
    Amministratore
    Beech Hill Road
    HU14 3QY Swanland
    The Hollies 7
    East Yorkshire
    UkBritish132410210001
    MCCANN, Leah
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    Amministratore
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    British51908280001
    NEWTON, Christopher John Landsborough
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    British101779200001
    SCANLAN, Sarah Rebecca
    26 Northfield Avenue
    Hessle
    HU13 9DL Hull
    North Humberside
    Amministratore
    26 Northfield Avenue
    Hessle
    HU13 9DL Hull
    North Humberside
    British55408650001
    TAYLOR, Malcolm
    9 Copper Beech Close
    Dunnington
    YO19 5PY York
    North Yorkshire
    Amministratore
    9 Copper Beech Close
    Dunnington
    YO19 5PY York
    North Yorkshire
    EnglandBritish83888440001
    TREBBLE, Stephen Paul
    The Laurels
    Main Street
    DN22 8DT Bothamsall
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Laurels
    Main Street
    DN22 8DT Bothamsall
    Nottinghamshire
    EnglandBritish76640730001
    WHITE, Norman
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    Amministratore
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    British29472760001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GATEWAY OFFSITE LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 16 nov 2009
    Consegnato il 20 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 16 nov 2009
    Consegnato il 20 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 nov 2009
    Consegnato il 18 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nvm Private Equity Limited
    Transazioni
    • 18 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 ott 2008
    Consegnato il 18 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nvm Private Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 18 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 set 2002
    Consegnato il 19 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Northern Venture Managers Limited
    Transazioni
    • 19 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 12 set 2002
    Consegnato il 19 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company and by any other company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 17 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 06 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Horncastle Group PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0