RWM DORSET LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRWM DORSET LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03454792
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RWM DORSET LIMITED?

    • Lavorazione e conservazione della carne (10110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova RWM DORSET LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Harlescott
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Shropshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RWM DORSET LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROMFORD WHOLESALE MEATS (DORSET) LIMITED20 nov 199720 nov 1997
    BROOMCO (1400) LIMITED24 ott 199724 ott 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di RWM DORSET LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per RWM DORSET LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Nomina di Mrs Janet Jennings come segretario in data 02 apr 2021

    2 pagineAP03

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2020

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 01 apr 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 30 apr 2018

    2 paginePSC09

    Notifica di Rwm Food Group Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 02 apr 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 27 mar 2016

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Thomas Francis Stephenson come amministratore in data 16 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Thomas Francis Stephenson come amministratore in data 30 set 2016

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Paul John Finnerty come amministratore in data 30 set 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul John Finnerty come amministratore in data 30 set 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul John Finnerty come amministratore in data 30 set 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 29 mar 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 nov 2015

    Stato del capitale al 02 nov 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ott 2014

    Stato del capitale al 28 ott 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Chi sono gli amministratori di RWM DORSET LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JENNINGS, Janet
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    Segretario
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    282226050001
    MCLAUGHLIN, John
    Rock Court
    Blackrock
    9
    County Louth
    Northern Ireland
    Segretario
    Rock Court
    Blackrock
    9
    County Louth
    Northern Ireland
    164135890001
    BURTON, John Michael
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandBritish158694740001
    KIRWAN, Thomas Joseph Lawrence, Mr.
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandIrish53766120001
    MICHAU, Peter James
    3 Littleworth Lane
    KT10 9PF Esher
    Lessworth
    Surrey
    Segretario
    3 Littleworth Lane
    KT10 9PF Esher
    Lessworth
    Surrey
    British35521130001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    COBDEN, Matthew Halsted
    Whitcombe Farm
    Ash
    TA12 6AH Martock
    Somerset
    Amministratore
    Whitcombe Farm
    Ash
    TA12 6AH Martock
    Somerset
    EnglandBritish35792480002
    COBDEN, William Noel Halstead
    The Westover Bungalow
    Whitcombe Farm
    TA12 6AH Martock
    Somerset
    Amministratore
    The Westover Bungalow
    Whitcombe Farm
    TA12 6AH Martock
    Somerset
    British78312910001
    EASTWOOD, Mark
    68 Marsh Lane
    BA21 3BY Yeovil
    Somerset
    Amministratore
    68 Marsh Lane
    BA21 3BY Yeovil
    Somerset
    EnglandBritish105113870002
    FINNERTY, Paul John
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    IrelandIrish138964760001
    HEFFER, Graham Keith
    14 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    14 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish118776840001
    HEFFER, Henry Robin
    Penthouse C
    82 Lilliput Rd
    BH14 8LA Poole
    Forsyte Shades
    Dorset
    Amministratore
    Penthouse C
    82 Lilliput Rd
    BH14 8LA Poole
    Forsyte Shades
    Dorset
    United KingdomBritish49020560002
    HEFFER, Robert Paul
    Mulberry House
    Laurel Drive
    BH18 8LJ Broadstone
    Dorset
    Amministratore
    Mulberry House
    Laurel Drive
    BH18 8LJ Broadstone
    Dorset
    United KingdomBritish49020570001
    MURPHY, David
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    IrelandIrish164125330001
    STEPHENSON, Thomas Francis
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    Amministratore
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    IrelandIrish217150530001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RWM DORSET LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Rwm Food Group Holdings Limited
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    .
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    .
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House, Cardiff
    Numero di registrazione6107425
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per RWM DORSET LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    24 ott 201606 mar 2018La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    RWM DORSET LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 09 ago 2011
    Consegnato il 19 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 lug 2010
    Consegnato il 21 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 14 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 31 ott 2007
    Consegnato il 01 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1000000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    New lamb slaughtering line s/n WP60071 & WP60072.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 16 nov 2006
    Consegnato il 17 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Reiser UK LTD supervac GK812B & AT15E robins hawkins engineering LTD effluent plant WT50093-50096.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 17 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 05 ago 2003
    Consegnato il 16 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The chattels the figa-bohn refridgeration equipment type PO73088/PP03814 (a) 2 x coolers SOP0015822 (a) SOP0015915 (a) 2 x condensing units SOP0015822(b) SOPP0015975(b), for details of further chattels charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 16 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 30 apr 1999
    Consegnato il 05 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £104,400 and all other monies due or to become due from he company to the chargee under the terms of the mortgage
    Brevi particolari
    1 x wbm 1350 conveyor vacuum packer with 1250 booster busch pump with serial no.6012HA110., 1 x stbw 60/80 electric shrink tunnel (72HA1606)., 1 x opal 6M conveyor and electrical control (OPD44779)., 1 x opal 1M conveyor and electrical control (A.22)., 1 x opal 3 tier packing container (A.33)., 1X opal 2M conveyor & electrical control no. Opo 44899., 1 x opal overhead roller track (A.11)., 1 x opal beef cutting line (A00). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 02 feb 1999
    Consegnato il 08 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the abbattoir chetnole road yetminster dorset t/no DT250109. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 08 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 mag 1998
    Consegnato il 13 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 08 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0