NEWMALL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEWMALL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03461909
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEWMALL LIMITED?

    • Attività combinate di servizi amministrativi d'ufficio (82110) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova NEWMALL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tricor Suite, 7th Floor
    52/54 Gracechurch Street
    EC3V 0EH London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEWMALL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HACKPLIMCO (NO.FORTY-TWO) PUBLIC LIMITED COMPANY06 nov 199706 nov 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEWMALL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per NEWMALL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    L0ORKS0I

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA
    AFCPJZV3

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    XII7MZQF

    Stato del capitale al 23 nov 2011

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19
    L33KKZHB

    legacy

    1 pagineSH20
    L33KLZHC

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    L33KMZHD

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 18/11/2011
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    3 pagineMG02
    L4NFGXBF

    legacy

    3 pagineMG02
    L4NFHXBG

    legacy

    3 pagineMG02
    L4NFIXBH

    legacy

    3 pagineMG02
    L4NFJXBI

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    X7124PTT

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA
    AVOQDNTC

    Indirizzo della sede legale modificato da Aquis Court 31 Fishpool Street St. Albans Hertfordshire AL3 4RF in data 22 mar 2010

    1 pagineAD01
    X5QORII7

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    X9U6JFFJ

    Dettagli del direttore cambiati per Frank Mensinger il 01 dic 2009

    2 pagineCH01
    X9U6IFFI

    Dettagli del direttore cambiati per Laurence Hurwitz il 01 dic 2009

    2 pagineCH01
    X9U6HFFH

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    13 pagineAA
    AJQEAEDY

    legacy

    1 pagine287
    AGKFQC8Z

    legacy

    3 pagine363a
    XPN4Y79R

    legacy

    1 pagine288a
    XPN4X79Q

    legacy

    1 pagine288b
    XPN4W79P

    legacy

    3 pagine363a
    XPC9K786

    Chi sono gli amministratori di NEWMALL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HURWITZ, Laurence
    2 Midlands Drive
    Avon
    Connecticut 06001
    Usa
    Segretario
    2 Midlands Drive
    Avon
    Connecticut 06001
    Usa
    AmericanCompany Director73371740001
    HURWITZ, Laurence
    2 Midlands Drive
    Avon
    Connecticut 06001
    Usa
    Amministratore
    2 Midlands Drive
    Avon
    Connecticut 06001
    Usa
    UsaAmericanCompany Director73371740001
    MENSINGER, Frank
    Kripes Road
    06026 East Granby
    11
    Ct
    Usa
    Amministratore
    Kripes Road
    06026 East Granby
    11
    Ct
    Usa
    UsaUnited StatesDirector, Taxation & Treasury136213570001
    DUCKWORTH, Simon Charles
    8 Newtons Croft Crescent
    Barlborough
    S43 4WA Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    8 Newtons Croft Crescent
    Barlborough
    S43 4WA Chesterfield
    Derbyshire
    British44867860001
    MATTINSON, Neil
    874 Bradford Road
    Birkenshaw
    BD11 2AT Bradford
    West Yorkshire
    Segretario
    874 Bradford Road
    Birkenshaw
    BD11 2AT Bradford
    West Yorkshire
    BritishAccountant61819200001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Segretario nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BAXTER, Alan John
    Grassways
    2 Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Grassways
    2 Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    BritishDirector35520050003
    KAES, Philip Ghislaine Charles
    24 August-Laemmle Weg
    Leonberg
    71229
    Germany
    Amministratore
    24 August-Laemmle Weg
    Leonberg
    71229
    Germany
    BritishDirector70420630001
    MURPHY, Kevin Andrew
    22 Chesterford Gardens
    Hampstead
    NW3 7DE London
    Amministratore
    22 Chesterford Gardens
    Hampstead
    NW3 7DE London
    BritishBanker35501380001
    RUTH , JR, John G
    15f Castle Hill Road
    Agawam
    Ma 01001
    Usa
    Amministratore
    15f Castle Hill Road
    Agawam
    Ma 01001
    Usa
    AmericanDirector & President70735930001
    SHIPMAN, Amanda Jane
    119 Ladbroke Road
    W11 3PR London
    Amministratore
    119 Ladbroke Road
    W11 3PR London
    BritishVenture Capitalist55909900001
    SMITH, Terence
    Sandhill House Sandhill Lane
    Sutton On Derwent
    YO41 4BX York
    Amministratore
    Sandhill House Sandhill Lane
    Sutton On Derwent
    YO41 4BX York
    EnglandBritishDirector42645420001
    WALTERS, Eric
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    Amministratore
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    BritishVenture Capitalist14107340001
    HACKWOOD DIRECTORS LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Amministratore delegato nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004840001

    NEWMALL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second lien deed of equitable mortgage and debt assignment
    Creato il 12 dic 2003
    Consegnato il 30 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first equitable mortgage the present security and the new rights, the future security and the new rights. Assigns the debts and all of its rights title benefits and interests to or in the debts together with all rights and remedies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston as Collateral Agent for the Lenders and Other Beneficiaries
    Transazioni
    • 30 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Amended and restated deed of equitable mortgage and debt assignment
    Creato il 12 dic 2003
    Consegnato il 30 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first equitable mortgage the present security and the new rights, the future security and the new rights. Assigns the debts and all of its rights title benefits and interests to or in the debts together with all rights and remedies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston as Collateral Agent for the Lenders and Other Beneficiaries
    Transazioni
    • 30 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 16 ott 1998
    Consegnato il 26 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of the company to the chargee now or hereafter existing under or arising out of or in connection with the guarantee, the security agreement and any other loan document together with all extensions or renewals thereof
    Brevi particolari
    The collateral (as defined) all right title and interest of the company in and to the equipment;the inventory and negotiable documents of title;the accounts and related contracts;the assigned agreement and the assigned agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Bostonas Collateral Agent for the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 26 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of equitable mortgage and assignment
    Creato il 16 ott 1998
    Consegnato il 26 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of the company to the chargee now or hereafter existing under or arising out of or in connection with the guarantee, the mortgage and any other loan documents together with all extensions or renewals thereof
    Brevi particolari
    By way of first equitable mortgage the present security; and the new rights..by way of first equitable mortgage when acquired by the company: the future security and the new rights which arise after the date of the mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Bostonas Collateral Agent for the Lenders and the Other Beneficiaries
    Transazioni
    • 26 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Second guarantee and debenture
    Creato il 20 feb 1998
    Consegnato il 12 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) all moneys and liabilities present or future due owing or incurred by the company or any other company named therein to each senior beneficiary under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and all money and liabilities due to each mezzanine beneficiary under or pursuant to the mezzanine finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First guarantee and debenture
    Creato il 18 dic 1997
    Consegnato il 06 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and/or the mezzanine finance documents
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all f/h and l/h land; by way of first fixed charge all plant and machinery, all rental and other income and all debts, all goodwill and uncalled capital, all book and other debts.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries (as Defined))
    Transazioni
    • 06 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0