PRACTICE PLUS GROUP HOSPITALS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PRACTICE PLUS GROUP HOSPITALS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03462881 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PRACTICE PLUS GROUP HOSPITALS LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova PRACTICE PLUS GROUP HOSPITALS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit H2, Harlequin Office Park, Fieldfair, Emersons Green, BS16 7FN Bristol England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PRACTICE PLUS GROUP HOSPITALS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CARE UK CLINICAL SERVICES LIMITED | 24 nov 2004 | 24 nov 2004 |
| CARE UK MEDICARE LIMITED | 17 gen 2000 | 17 gen 2000 |
| PROSPECS LIMITED | 10 nov 1997 | 10 nov 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PRACTICE PLUS GROUP HOSPITALS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2027 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PRACTICE PLUS GROUP HOSPITALS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 08 nov 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 22 nov 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 08 nov 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per PRACTICE PLUS GROUP HOSPITALS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, 1330 Arlington Business Park Theale Reading RG7 4SA England a Unit H2, Harlequin Office Park, Fieldfair, Emersons Green, Bristol BS16 7FN in data 05 mag 2026 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2025 | 61 pagine | AA | ||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2026 al 31 mar 2027 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 034628810014, creata il 28 nov 2025 | 63 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 11 pagine | MA | ||||||||||||||
Notifica di Narayana Hrudayalaya Uk Ltd come persona con controllo significativo il 06 nov 2025 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Cessazione di Practice Plus Group Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 nov 2025 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Anesh Shetty come amministratore in data 06 nov 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Amicorp (Uk) Secretaries Limited come segretario in data 12 nov 2025 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||||||
Nomina di Ms Terri Smith Bresenham come amministratore in data 06 nov 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Lee Stafford Gage come segretario in data 06 nov 2025 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Colman Moher come amministratore in data 06 nov 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 034628810013 | 1 pagine | MR05 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 ott 2025
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 31 ott 2025
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2024 | 61 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW England a Ground Floor, 1330 Arlington Business Park Theale Reading RG7 4SA in data 19 ago 2024 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2023 | 66 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PRACTICE PLUS GROUP HOSPITALS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMICORP (UK) SECRETARIES LIMITED | Segretario | 5 Lloyd's Avenue EC3N 3AE London 3rd Floor England |
| 76414340002 | ||||||||||
| BRESENHAM, Terri Smith | Amministratore | Harlequin Office Park, Fieldfair, Emersons Green, BS16 7FN Bristol Unit H2, England | United States | American | 342602650001 | |||||||||
| DOWSETT, Ross Martin, Mr. | Amministratore | Harlequin Office Park, Fieldfair, Emersons Green, BS16 7FN Bristol Unit H2, England | England | British | 306409940001 | |||||||||
| EASTON, James William | Amministratore | Harlequin Office Park, Fieldfair, Emersons Green, BS16 7FN Bristol Unit H2, England | United Kingdom | British | 118320980001 | |||||||||
| SHETTY, Anesh | Amministratore | Harlequin Office Park, Fieldfair, Emersons Green, BS16 7FN Bristol Unit H2, England | Cayman Islands | Indian | 342603840001 | |||||||||
| BOOKER, Roger Ian | Segretario | 4 Southgate Gardens Long Melford CO10 9HB Sudbury Suffolk | British | 14044530002 | ||||||||||
| BUDHDEO, Kalpna | Segretario | 48a Paines Lane HA5 3DA Pinner Middlesex | British | 43407720003 | ||||||||||
| CALOW, Jonathan David | Segretario | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | 165437830001 | |||||||||||
| GAGE, Lee Stafford | Segretario | Theale RG7 4SA Reading Ground Floor, 1330 Arlington Business Park England | 282066920001 | |||||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Segretario | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | 33223550003 | ||||||||||
| CARE UK SERVICES LIMITED | Segretario | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125332040002 | ||||||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||||||
| BOOKER, Roger Ian | Amministratore | 4 Southgate Gardens Long Melford CO10 9HB Sudbury Suffolk | British | 14044530002 | ||||||||||
| BRYANT, James Richard Stansfeld | Amministratore | Drapers Farmhouse Rushden SG9 0TB Buntingford Hertfordshire | England | British | 7897550001 | |||||||||
| BUDHDEO, Kalpna | Amministratore | 48a Paines Lane HA5 3DA Pinner Middlesex | England | British | 43407720003 | |||||||||
| BUDHDEO, Samir Pravin | Amministratore | 48a Paines Lane HA5 3DA Pinner Middlesex | England | British | 43407750001 | |||||||||
| CLOUGH, Richard Stanley | Amministratore | Hanini 50 Second Avenue CO13 9LX Frinton On Sea Essex | England | British | 7897560001 | |||||||||
| CULHANE, Angela | Amministratore | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 68602910001 | |||||||||
| DEANS, Ian David | Amministratore | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 133139220001 | |||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Amministratore | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||||||
| HUNT, Mark Atkinson, Dr | Amministratore | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 129906070001 | |||||||||
| JATHANNA, Sushil Devaprasad, Dr | Amministratore | Lyndhurst Plains Farm Close Ardleigh CO7 7QU Colchester Essex | United Kingdom | Indian | 103456550001 | |||||||||
| MOHER, Colman | Amministratore | Theale RG7 4SA Reading Ground Floor, 1330 Arlington Business Park England | England | Irish | 195751220003 | |||||||||
| PARISH, Michael Robert | Amministratore | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 78828750003 | |||||||||
| PROSSER, Andrew James Mackenzie | Amministratore | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | 151240810001 | |||||||||
| RUSSELL, Andrew Philip Thomas | Amministratore | 37 Woodley Lane SO51 7JL Romsey Hampshire | England | British | 23099130001 | |||||||||
| STICKLAND, David George | Amministratore | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | United Kingdom | British | 130704670001 | |||||||||
| WHITECROSS, Philip James | Amministratore | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 193730760001 | |||||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PRACTICE PLUS GROUP HOSPITALS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narayana Hrudayalaya Uk Ltd | 06 nov 2025 | 5 Lloyds Avenue EC3N 3AE London 3rd Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Practice Plus Group Holdings Limited | 06 apr 2016 | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0