PANTHERIX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPANTHERIX LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03464985
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PANTHERIX LIMITED?

    • Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PANTHERIX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o JOHNSTON CARMICHAEL
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PANTHERIX LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AZTECEQUAL LIMITED13 nov 199713 nov 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di PANTHERIX LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per PANTHERIX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 dic 2016

    7 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Excalibur Fund Managers Ltd Berkeley Square House Berkeley Square Mayfair London W15 6BD a C/O Johnston Carmichael 107-111 Fleet Street London EC4A 2AB in data 11 gen 2016

    3 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 dic 2015

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 dic 2014

    Stato del capitale al 17 dic 2014

    • Capitale: GBP 41,822.24
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2014

    11 pagineAA

    Nomina di Farhad Fred Fahid come amministratore

    3 pagineAP01
    Note
    DataNota
    10 giu 2020Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 10/06/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2013

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    13 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 nov 2013

    Stato del capitale al 26 nov 2013

    • Capitale: GBP 41,822.237
    SH01

    Cessazione della carica di Mark Docherty come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark James Docherty il 07 feb 2013

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2012

    14 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2011

    11 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 nov 2010

    14 pagineAR01

    Nomina di Alexander Morrison Mcdougall come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Alexander Morrison Mcdougall come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di John Gonzalez-Carvajal come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PANTHERIX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    Hazelden Road
    Mearnskiry
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    Segretario
    Hazelden Road
    Mearnskiry
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    British156743750001
    FAHID, Farhad
    W8
    Amministratore
    W8
    EnglandBritish186461120001
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    c/o Johnston Carmichael
    Fleet Street
    EC4A 2AB London
    107-111
    Amministratore
    c/o Johnston Carmichael
    Fleet Street
    EC4A 2AB London
    107-111
    United KingdomBritish67155220007
    DOCHERTY, Mark James
    9 The Lye
    Little Gaddesden
    HP4 1UH Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    9 The Lye
    Little Gaddesden
    HP4 1UH Berkhamsted
    Hertfordshire
    British47388290002
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    Segretario
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    British67155220005
    WHITROW, Jane Elizabeth, Dr
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    Segretario
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British78788220001
    ATLANTIC CORRIE LTD (SC280885)
    Hazelden Road
    Mearnskirk
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    Segretario
    Hazelden Road
    Mearnskirk
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    107928480001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENEDICT, Nicholas Matthew
    Spalentorheg 31
    Basel 4051
    Switzerland
    Amministratore
    Spalentorheg 31
    Basel 4051
    Switzerland
    British131280480001
    CLARK, Alan Stuart
    Kings Barn
    Bentworth
    GU34 5JU Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Kings Barn
    Bentworth
    GU34 5JU Alton
    Hampshire
    British67234920002
    COOPER, Robin David Grey
    6740 Dover Road
    FOREIGN Indianapolis
    Indiana 46220
    Usa
    Amministratore
    6740 Dover Road
    FOREIGN Indianapolis
    Indiana 46220
    Usa
    British-Us77211370001
    D'ORSA, Salvatore
    33 King Stret
    SW1Y 6RJ London
    Amministratore
    33 King Stret
    SW1Y 6RJ London
    Italian95545080003
    DOCHERTY, Mark James
    c/o Avlar Bioventures Ltd
    Church Lane
    CB23 8AG Madingley
    Highfield Court
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    c/o Avlar Bioventures Ltd
    Church Lane
    CB23 8AG Madingley
    Highfield Court
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritish47388290006
    FREEMAN, George William
    13 Warwick Square
    SW1V 2AB London
    Amministratore
    13 Warwick Square
    SW1V 2AB London
    British70152070002
    GENNERY, Brian Albert, Dr
    6 Qualitas
    RG12 7QG Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    6 Qualitas
    RG12 7QG Bracknell
    Berkshire
    United KingdomBritish89422310001
    GONZALEZ-CARVAJAL, John Ramon, Dr
    Piazzale F Baracca 1
    20123 Milano
    Italy
    Amministratore
    Piazzale F Baracca 1
    20123 Milano
    Italy
    British74227120004
    GREENE, Andrew Fay
    18 Caithness Road
    W14 0JA London
    Amministratore
    18 Caithness Road
    W14 0JA London
    EnglandAmerican86855850001
    HOLT, Elizabeth
    East Garnet House
    Caup Road
    SW19 4UW London
    Amministratore
    East Garnet House
    Caup Road
    SW19 4UW London
    British73547900001
    KEEN, Peter Stephen
    26 Manor Road
    Hemingford Grey
    PE28 9BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    26 Manor Road
    Hemingford Grey
    PE28 9BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish38560002
    LATHAM, Christopher John, Dr
    6 North Gardner Street
    G11 5BT Glasgow
    Amministratore
    6 North Gardner Street
    G11 5BT Glasgow
    British78599550002
    MACDONALD, Cameron Mackay
    10 Paxton Close
    MK46 5PR Olney
    Buckinghamshire
    Amministratore
    10 Paxton Close
    MK46 5PR Olney
    Buckinghamshire
    EnglandBritish56171470001
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    Amministratore
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    British67155220005
    POWELL, Kenneth Leslie, Professor
    Wheatfields Hill Boxes Farm
    Marden Park Woldingham
    CR3 7JD Caterham
    Surrey
    Amministratore
    Wheatfields Hill Boxes Farm
    Marden Park Woldingham
    CR3 7JD Caterham
    Surrey
    British50259160001
    SHAW, William Vare, Professor
    1 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    1 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    Lanarkshire
    American57716570002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    PANTHERIX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture creating a floating charge
    Creato il 01 lug 2004
    Consegnato il 19 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the property, assets and undertaking of the company whatsoever, both present and future including, without limitation, any goodwill and any unpaid share capital of the company;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merlin Biosciences Fund L.P. Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited,Merlin Biosciences Fund Gbr, Acting by Its Managing Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transazioni
    • 19 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture creating a floating charge
    Creato il 27 feb 2004
    Consegnato il 19 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    And any goodwill and any unpaid share capital. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Merlin Biosciences Fund L.P. and Merlin Biosciences Fund Gbr and Mb Venture Capital Fund 1 Nv
    Transazioni
    • 19 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture creating a floating charge
    Creato il 10 ott 2003
    Consegnato il 22 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Merlin Biosciences Fund LP Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transazioni
    • 22 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amended and restated convertible secured promissory note
    Creato il 08 ott 2003
    Consegnato il 20 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    $2,500,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All of the company's right, title and interest in and to any and all intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gpc Biotech Ag
    Transazioni
    • 20 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 mag 2003
    Consegnato il 30 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the property, assets and undertaking of the company whatsoever, both present and future, including, without limitation, any goodwill and any unpaid share capital of the company.
    Persone aventi diritto
    • Merlin Biosciences Fund LP Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited Andmerlin Biosciences Fund Gbr Acting by Its Managing Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transazioni
    • 30 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 apr 2003
    Consegnato il 22 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All of the proerty assets and undertaking of the company whatsoever both present and future including without limitation any goodwill and any unpaid share capital of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merlin Bioscience Fund LP, Merlin Biosciences Fund Gbr & Mb Venture Capital Fund 1 Nv
    Transazioni
    • 22 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible secured promissory note
    Creato il 22 ago 2002
    Consegnato il 03 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $2,500,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the company's right, title and interest in and to any and all intellectual property rights that are conceived, discovered, identified or first reduced to practice by the company's exercise or certain of the company's rights under the licence agreement.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gpc Biotech Ag
    Transazioni
    • 03 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture creating a floating charge
    Creato il 05 giu 2002
    Consegnato il 25 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Merlin Bioscience Fund LP Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transazioni
    • 25 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 11 gen 2000
    Consegnato il 31 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future liabilities of the company to the chargee under pursuant to or in connection with the facility letter dated 11TH january 2000 (together with any letter, deed, documents or other agreement present or future confirming, varying, amending or supplementing such letter) and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brevi particolari
    All of the property, assets and undertaking of the company whatsoever both present and future including without limitation any goodwill and any unpaid share capital of the company.
    Persone aventi diritto
    • Merlin General Partner Limited
    Transazioni
    • 31 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PANTHERIX LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 dic 2015Inizio della liquidazione
    12 apr 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Purdon Henderson
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    Praticante
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0