COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD

COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03466168
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD?

    • (7011) /

    Dove si trova COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Four
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COFTON LAND & PROPERTY (NORTHANTS) LTD05 mag 199805 mag 1998
    COFTON LAND & PROPERTY (ESSEX) LIMITED21 nov 199721 nov 1997
    BROADPIP LIMITED14 nov 199714 nov 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2007

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 19 gen 2016

    20 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 13 gen 2016

    20 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 lug 2015

    36 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 gen 2015

    41 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 lug 2014

    41 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 gen 2014

    24 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 lug 2013

    24 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 gen 2013

    24 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 lug 2012

    26 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 gen 2012

    23 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 lug 2011

    15 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 gen 2011

    15 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 lug 2010

    16 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 gen 2010

    16 pagine2.24B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    30 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B/2.14B

    9 pagine2.16B

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STANTON, Andrew John
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    Segretario
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    BritishCompany Director85663460002
    BARNSDALL, Thomas Edward
    Marslands Farm Church Lane
    Corley
    CV7 8AS Coventry
    Amministratore
    Marslands Farm Church Lane
    Corley
    CV7 8AS Coventry
    United KingdomBritishCompany Director58085470001
    INNES, Clive Alexander
    Keepers Cottage
    Lower Binton
    CV37 9TE Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Keepers Cottage
    Lower Binton
    CV37 9TE Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishDirector11962870001
    STANTON, Andrew John
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    Amministratore
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director85663460002
    TURNER, Stephen Roger
    5 Walsall Road
    B74 4ND Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    5 Walsall Road
    B74 4ND Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishDirector65282970001
    POSTLETHWAITE, Philip
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Director20147100001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    NELSON, Peter
    14 Tudor Hill
    B73 6BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    14 Tudor Hill
    B73 6BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector101543330002
    POSTLETHWAITE, Philip
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Director20147100001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 27 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment
    Creato il 20 dic 2006
    Consegnato il 09 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £3,208,388 together with all rights, powers, privileges. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 20 dic 2006
    Consegnato il 09 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £3,208,388 together with all rights, powers, privileges. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 20 dic 2006
    Consegnato il 09 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £5,044,850 together with all rights, powers, privileges. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 20 dic 2006
    Consegnato il 09 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £1,000,000 together with all rights, powers, privileges. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Sub-mortgage
    Creato il 31 dic 2004
    Consegnato il 12 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgage debt and the benefit of all covenants powers and provisions contained in or conferred by the watton mortgage and all securities for them and generally the whole benefit of the watton mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Castlemore (Watton) Limited
    Transazioni
    • 12 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation
    Creato il 02 dic 2004
    Consegnato il 31 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,250.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at raf watton more particularly described in the mortgage.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Trading Company Limited
    Transazioni
    • 31 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 lug 2004
    Consegnato il 09 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Sub-mortgage
    Creato il 29 mar 2004
    Consegnato il 14 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A mortgage dated 29 march 2004 relating to part of the land being k/a the former technical site raf watton, watton norfolk part t/n's NK254098 and NK254099.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment of debt
    Creato il 29 mar 2004
    Consegnato il 14 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £6,181,055.00 together with interest and expenses due and payable on 1 october 2004.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 2004
    Consegnato il 16 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land being part of the former technical site raf watton, watton norfolk part t/n's NK254098 and NK254099. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 29 mar 2004
    Consegnato il 14 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,250,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land being part of the former technical site raf watton, watton norfolk part t/n's NK254098 and NK254099.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Trading Company Limited
    Transazioni
    • 14 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    COFTON LAND & PROPERTY (DEVELOPMENTS) LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 gen 2016Fine dell'amministrazione
    23 lug 2009Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Charles Reid
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Praticante
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Praticante
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0