VARLEY PUMPS LIMITED

VARLEY PUMPS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVARLEY PUMPS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03467902
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VARLEY PUMPS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova VARLEY PUMPS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Kimpton Road
    Luton
    LU1 3LD Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VARLEY PUMPS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DE FACTO 678 LIMITED18 nov 199718 nov 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di VARLEY PUMPS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per VARLEY PUMPS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mag 2018

    2 pagineAA

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2017

    2 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2018 al 31 mag 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Hayward Tyler Group Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Ewan Royston Lloyd Baker come amministratore in data 31 ago 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Michael King come amministratore in data 31 ago 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 gen 2016

    Stato del capitale al 04 gen 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 nov 2014

    Stato del capitale al 16 nov 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    10 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2013

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 nov 2013

    Stato del capitale al 19 nov 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 16 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Specialist Energy Group Plc 19 Crown Passage London SW1Y 6PP United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di VARLEY PUMPS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KING, Stephen Michael
    1 Kimpton Road
    Luton
    LU1 3LD Bedfordshire
    Amministratore
    1 Kimpton Road
    Luton
    LU1 3LD Bedfordshire
    EnglandBritish84235400004
    BALLENTINE, Norman Mcara
    5 Ashdale Park
    RG40 3QS Finchampstead
    Berkshire
    Segretario
    5 Ashdale Park
    RG40 3QS Finchampstead
    Berkshire
    British77926160001
    COESHALL, Elizabeth
    Newland Street
    CM8 1AH Witham
    72a
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    Newland Street
    CM8 1AH Witham
    72a
    Essex
    United Kingdom
    Other139443050001
    GRAY, Claire Laura
    Shire Barn, School Road
    Copford Green, Copford
    CO6 1BZ Colchester
    Segretario
    Shire Barn, School Road
    Copford Green, Copford
    CO6 1BZ Colchester
    British32016350003
    JACKSON, Kim Lee
    1 Curzon Place
    Old Farm Park
    MK7 8RB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    1 Curzon Place
    Old Farm Park
    MK7 8RB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British63570400001
    KENDALL, Philip Harold Malcolm, Mr.
    21 West End
    Brampton
    PE28 4SD Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    21 West End
    Brampton
    PE28 4SD Huntingdon
    Cambridgeshire
    British70888320002
    LANGRIDGE, Nicola Jane
    32 Seamons Close
    LU6 3EQ Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    32 Seamons Close
    LU6 3EQ Dunstable
    Bedfordshire
    British59986880001
    LEWIS, Liza Marie
    32 Ravencroft
    OX6 0YQ Bicester
    Oxfordshire
    Segretario
    32 Ravencroft
    OX6 0YQ Bicester
    Oxfordshire
    British65894530001
    MALONEY, Adam Paul
    65 Trajan Gate
    SG2 7QQ Stevenage
    Hertfordshire
    Segretario
    65 Trajan Gate
    SG2 7QQ Stevenage
    Hertfordshire
    British62655860001
    RIDLEY, Ian
    8 The Crest
    LU3 2LE Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    8 The Crest
    LU3 2LE Luton
    Bedfordshire
    British56015010001
    SMITH, Robin Oliver
    31 Howes Drive
    Marston Moretaine
    MK43 0FD Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    31 Howes Drive
    Marston Moretaine
    MK43 0FD Bedford
    Bedfordshire
    British75404030002
    WALTERS, Nicholas John
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    Segretario
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    British38462890002
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Segretario nominato
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Segretario nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BALLENTINE, Norman Mcara
    5 Ashdale Park
    RG40 3QS Finchampstead
    Berkshire
    Amministratore
    5 Ashdale Park
    RG40 3QS Finchampstead
    Berkshire
    British77926160001
    DART, Geoffrey Gilbert
    103a Ashley Gardens
    Thirleby Road
    SW1P 1HJ London
    Amministratore
    103a Ashley Gardens
    Thirleby Road
    SW1P 1HJ London
    EnglandBritish76453360007
    GREENWELL, Kevin
    234 Cutenhoe Road
    LU3 4DU Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    234 Cutenhoe Road
    LU3 4DU Luton
    Bedfordshire
    British56015980002
    JACKSON, Kim Lee
    1 Curzon Place
    Old Farm Park
    MK7 8RB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Curzon Place
    Old Farm Park
    MK7 8RB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British63570400001
    KENDALL, Philip Harold Malcolm, Mr.
    21 West End
    Brampton
    PE28 4SD Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    21 West End
    Brampton
    PE28 4SD Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish70888320002
    LLOYD BAKER, Ewan Royston
    Beecham House
    The Street West Winterlow
    SP5 1RY Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Beecham House
    The Street West Winterlow
    SP5 1RY Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish102945080001
    MALONEY, Adam Paul
    65 Trajan Gate
    SG2 7QQ Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    65 Trajan Gate
    SG2 7QQ Stevenage
    Hertfordshire
    British62655860001
    RIDLEY, Ian
    8 The Crest
    LU3 2LE Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    8 The Crest
    LU3 2LE Luton
    Bedfordshire
    British56015010001
    WALTERS, Nicholas John
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    Amministratore
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    British38462890002
    WEARING, Gary
    77 Hampden Road
    SG4 0LB Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    77 Hampden Road
    SG4 0LB Hitchin
    Hertfordshire
    British65188100001
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore delegato nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore delegato nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VARLEY PUMPS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Kimpton Road
    LU1 3LD Luton
    1
    England
    06 apr 2016
    Kimpton Road
    LU1 3LD Luton
    1
    England
    No
    Forma giuridicaCompany
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3232768
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    VARLEY PUMPS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 24 nov 2006
    Consegnato il 02 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2006
    Consegnato il 30 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 02 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Investments PLC (Acting for Itself and as Security Trustee for 3I Group PLC and 3ITMENT Partners LP(for Further Details of Chargee
    • 3I Investments PLC (Acting for Itself and as Security Trustee for 3I Group PLC and 3IS See from 395)
    • 3I Investments PLC (Acting for Itself and as Security Trustee for 3I Group PLC and 3IINVESTMENT Partners LP) 3I Group PLC,3I UK Inves
    Transazioni
    • 02 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 06 mar 2006
    Consegnato il 15 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Venture Finance PLC
    Transazioni
    • 15 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 dic 1997
    Consegnato il 29 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor,guarantor,surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of hayward tyler group limited (formerly known as de facto 521 limited) and its subsidiary undertakings from time to time to 3I PLC (the "security trustee") and/or 3I group PLC and 3I UK investment partners and any person who is designated a lender under clause 23 of the mezzanine loan agreement (as defined) in whatever manner and on any account including,but not limited to,under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 11 dic 1997
    Consegnato il 19 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of each obligor to the chargee in whatever manner and on any account including but not limited to the financing documents together with all costs, charges and expenses incurred by the chargee in connection with the protection, preservation or enforcement of its rights under the financing documents or otherwise
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0