TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED

TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03468484
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LIFESTYLE HOUSEHOLD UNDERWRITING AGENCY LIMITED19 nov 199719 nov 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Towergate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN a 92 London Street Reading Berkshire RG1 4SJ in data 23 giu 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 giu 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 nov 2014

    Stato del capitale al 21 nov 2014

    • Capitale: GBP 95
    SH01

    Cessazione della carica di Mark Steven Hodges come amministratore in data 17 ott 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Nomina di Jennifer Owens come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 nov 2013

    Stato del capitale al 22 nov 2013

    • Capitale: GBP 95
    SH01

    Cessazione della carica di Samuel Clark come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Cullum come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Mark Steven Hodges come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Philip come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Scott Egan come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Andrew Hunter come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Samuel Thomas Budgen Clark come segretario

    1 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Stewart Hunter come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Darryl Clark come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OWENS, Jennifer
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Segretario
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    183297080001
    EGAN, Scott
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Amministratore
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    EnglandBritish170703910001
    ALEXANDER, Peter
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    Segretario
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    British60245740001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    153032640001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    161873210001
    CRATON, Timothy Charles
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Segretario
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    British76055420004
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Segretario
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    British99424380001
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    156608080001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Segretario
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    British6180280001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    CROCKER, Nicholas John David
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    Amministratore
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    British60697560014
    CROWTHER, Roger
    167 Arnold Avenue
    Gleadless
    S12 3JD Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    167 Arnold Avenue
    Gleadless
    S12 3JD Sheffield
    South Yorkshire
    British42039250001
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Amministratore
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    EnglandBritish59873490009
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Amministratore
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    EnglandBritish99424380001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Amministratore
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United KingdomBritish58444370003
    PHILIP, Timothy Duncan
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    United KingdomBritish99066410001
    PROVERBS, Antony
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    Amministratore
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    EnglandBritish79185700012
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 ago 2001
    Consegnato il 13 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (the agent), the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank, the hedging bank, the zero per cent lenders, the investors and to any of them on any account whatsoever including without limitation under any of the financing documents (all terms as defined)
    Brevi particolari
    (Other than f/h property k/a 317 woodham lane new haw t/no.SY350608 and the f/h land at the south west of scotland bridge road new haw t/no.SY536467 in each case so long as the same is charged by towergate chase parkinson limited to coutts & co). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Creato il 15 mag 2001
    Consegnato il 23 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein ("the chargors") to the chargee pursuant to the framework agreement or the charge
    Brevi particolari
    The assigned rights being all the rights, titles, benefits and interests of the company to the commissions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Insurance Limited
    Transazioni
    • 23 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 07 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender, the Mezzanine Lender, the Overdraft Bank, the Hedging Bank and the Investor (All as Defined)
    Transazioni
    • 07 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 18 dic 1998
    Consegnato il 06 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Mezzanine Limited,as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender,the Overdraftbank,the Hedging Bank and the Investors (All Asdefined)
    Transazioni
    • 06 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 giu 2015Inizio della liquidazione
    28 gen 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David William Tann
    Wilkins Kennedy Llp
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Praticante
    Wilkins Kennedy Llp
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Matthew John Waghorn
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Praticante
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0