STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED

STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03477150
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5FY Altrincham
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HEADWORX (EUROPE) LIMITED05 dic 199705 dic 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Grenville Rusby il 27 dic 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Grenville Rusby il 27 dic 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 nov 2009

    Stato del capitale al 27 nov 2009

    • Capitale: GBP 1,200,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    14 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    15 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    15 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2004

    18 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    2 pagine88(2)R

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di aumento del capitale sociale autorizzato

    RES04

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagine123

    Bilancio redatto al 31 mar 2003

    17 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Working capital facilit 16/12/03
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RUSBY, Peter Grenville
    Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5FY Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5FY Altrincham
    Cheshire
    British16859340003
    BENTWOOD, Steven Michael
    Bankhall Corner
    110 Bankhall Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    Amministratore
    Bankhall Corner
    110 Bankhall Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish93615070002
    RUSBY, Peter Grenville
    Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5FY Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5FY Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish16859340004
    WHITE, Angela Frances
    Little Bourne Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    Segretario
    Little Bourne Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    British48383080001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    GOWER, David Kevin
    Little Bown Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    Amministratore
    Little Bown Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    British37899800002
    SOLOMON, Peter Loris
    House 127, The Portofino
    88-188 Pak To Avenue Clearwater Bay
    Sai Kung New Territories
    Hong Kong
    Amministratore
    House 127, The Portofino
    88-188 Pak To Avenue Clearwater Bay
    Sai Kung New Territories
    Hong Kong
    Australian111531540004
    WHITE, Angela Frances
    Little Bourne Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    Amministratore
    Little Bourne Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    British48383080001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 nov 2001
    Consegnato il 14 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 giu 2001
    Consegnato il 04 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement or otherwise
    Brevi particolari
    (I) by way of fixed charge any present or future debt the ownership of which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (the factored debts) and (ii) all amounts of indebtedness due to the company on any account whatsoever other than the factored debts (the other debts).by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets.
    Persone aventi diritto
    • Bibby Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 04 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 lug 2000
    Consegnato il 31 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 04 ago 1999
    Consegnato il 06 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge over all debts purchased with all associated rights thereon.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Credit Services Limited
    Transazioni
    • 06 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0