FAREBROTHER GROUP LIMITED

FAREBROTHER GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFAREBROTHER GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03477861
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 lug 2012

    Stato del capitale al 04 lug 2012

    • Capitale: GBP 67,492
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Smith il 14 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Arthur Edward Gee il 14 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per John Edwards il 14 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Martin Paul Wrigley il 14 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    17 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    18 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    22 pagineAA

    legacy

    8 pagine155(6)b

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assistenza finanziaria per l'acquisizione di azioni

    RES07

    legacy

    9 pagine155(6)a

    Chi sono gli amministratori di FAREBROTHER GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WRIGLEY, Martin Paul
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    Segretario
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    British114395980001
    EDWARDS, John
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    Amministratore
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    EnglandBritish60296400001
    GEE, Arthur Edward
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    Amministratore
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    EnglandBritish60296640001
    BROMLEY, Tracey Helen
    100 Sheffield Road
    SK14 2PL Hyde
    Cheshire
    Segretario
    100 Sheffield Road
    SK14 2PL Hyde
    Cheshire
    British49508780002
    STEWARD, Karen Mary
    Windsor House
    24 Werneth Road Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    Segretario
    Windsor House
    24 Werneth Road Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    British60296780002
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BROMLEY, Tracey Helen
    100 Sheffield Road
    SK14 2PL Hyde
    Cheshire
    Amministratore
    100 Sheffield Road
    SK14 2PL Hyde
    Cheshire
    British49508780002
    EDWARDS, John
    17 Moss Bank Road
    Swinton
    M27 9UJ Manchester
    Amministratore
    17 Moss Bank Road
    Swinton
    M27 9UJ Manchester
    EnglandBritish60296400001
    JOHNSON, John
    17 Seagrave Close
    CW9 8UR Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    17 Seagrave Close
    CW9 8UR Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish100740730001
    PEAKE, John
    7 Orrishmere Road
    SK8 5HP Cheadle Hulme
    Cheshire
    Amministratore
    7 Orrishmere Road
    SK8 5HP Cheadle Hulme
    Cheshire
    British74261470001
    SMITH, Martin Philip
    3 The Circuit
    Cheadle Hulme Cheadle
    SK3 9RN Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    3 The Circuit
    Cheadle Hulme Cheadle
    SK3 9RN Stockport
    Cheshire
    British87763320001
    SMITH, Michael
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    Amministratore
    Ridgway House Progress Way
    Windmill Lane
    M34 2GP Denton
    Manchester
    EnglandBritish114796520004
    STEWARD, John
    Windsor House 24 Werneth Road
    Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Windsor House 24 Werneth Road
    Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish55224920003
    STEWARD, Karen Mary
    Windsor House
    24 Werneth Road Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Windsor House
    24 Werneth Road Woodley
    SK6 1HP Stockport
    Cheshire
    British60296780002
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    FAREBROTHER GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assignment of rental income
    Creato il 23 dic 2004
    Consegnato il 06 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All payments as rent under the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 06 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Commercial mortgage deed
    Creato il 23 dic 2004
    Consegnato il 06 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land adjoining millenium house new century house and the warehouse denton manchester t/no: GM531291 the goodwill of any business. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 06 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 giu 2003
    Consegnato il 27 giu 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 15 gen 2003
    Consegnato il 16 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of windmill lane denton manchester k/a millenium house and new century house t/no GM884124. Assignment of the goodwill. The benefit of the licence or certificate. The right to recover and receive any compensation. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 25 set 2002
    Consegnato il 27 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking, property and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 27 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of rental income
    Creato il 25 set 2002
    Consegnato il 27 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The lease dated 18 september 2002; the lease dated 16 september 2002 and any lease of the whole or part of the land k/a land on the north west side of windmill lane denton.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 27 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Commercial mortgage deed
    Creato il 25 set 2002
    Consegnato il 27 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property briefly k/a land on the north west side of windmill lane denton t/no GM884124 together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. By way of first fixed charge all the goodwill, the full benefit of licences, any shareholding issued and uncalled capital. By way of fixed equitable charge all estates or interest in any land. By way of assignment the rights to receive payments reserved as rent.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 27 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 giu 2001
    Consegnato il 26 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at windmill lane, denton, manchester t/n GM366585 (by way of legal charge). All fixtures and fittings and all fixed plant and machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sale acts). A floating charge over all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment and assigns the goodwill of the business carried on at or from the property and the benefit of the licence or certificate the right to recover and receive any compensation payable in respect of the licence or certificate.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 giu 1998
    Consegnato il 18 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0