ATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED

ATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03479641
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova ATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bridgeway House
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MORETHANHOTELS (BIRMINGHAM) LIMITED25 nov 200525 nov 2005
    FOREMOST HOTELS (BIRMINGHAM) LIMITED30 mag 200330 mag 2003
    INGRAM HOTELS (BIRMINGHAM) LIMITED14 lug 199814 lug 1998
    ROADCHEF (BIRMINGHAM) LIMITED11 dic 199711 dic 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di ATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 034796410007 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Adrian Paul Bradley come amministratore in data 19 mar 2019

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Keith Ian Griffiths come amministratore in data 05 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Sean Joseph Lowe come amministratore in data 05 gen 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Memorandum e Statuto

    16 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 034796410007, creata il 03 nov 2017

    101 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 034796410006 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 dic 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da No.1 London Bridge London SE1 9BG England a Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW

    1 pagineAD02

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 dic 2016 al 30 set 2016

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 034796410005 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    18 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 034796410006, creata il 21 giu 2016

    89 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di ATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRADLEY, Adrian Paul
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    United KingdomBritish90379240002
    LOWE, Sean Joseph
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish195752560001
    COMPTON, Anne
    Ladycross Boddington Road
    Staverton
    GL51 0TN Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Ladycross Boddington Road
    Staverton
    GL51 0TN Cheltenham
    Gloucestershire
    British54419370001
    INGRAM HILL, Sarah
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    Segretario
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    British59327230001
    MCCOLL, Fraser Robert
    Broom Cottage
    1 Lodge Lane
    TN16 1RH Westerham
    Kent
    Segretario
    Broom Cottage
    1 Lodge Lane
    TN16 1RH Westerham
    Kent
    British70649620002
    PENDRILL, Richard William
    Boscobel Sweetwater Lane
    Wormley
    GU8 5SS Godalming
    Surrey
    Segretario
    Boscobel Sweetwater Lane
    Wormley
    GU8 5SS Godalming
    Surrey
    British5919770001
    WARWICK, Timothy James
    Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno
    St Fagans
    CF5 4PJ Cardiff
    Wales
    Segretario
    Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno
    St Fagans
    CF5 4PJ Cardiff
    Wales
    British65745040001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    BARNES, Robert Digby Phillips
    Brampton Chase
    Summerhouse Road
    GU7 1PY Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Brampton Chase
    Summerhouse Road
    GU7 1PY Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish59539070002
    BELL, Alastair Marshall
    8 Thackeray Close
    Wimbledon
    SW19 4JL London
    Amministratore
    8 Thackeray Close
    Wimbledon
    SW19 4JL London
    EnglandBritish87778630001
    COUTURIER, Philippe
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    EnglandFrench185748330001
    DARLING, Mervyn
    St James's House
    Charlotte Street
    M1 4DZ Manchester
    Allied Irish Bank
    United Kingdom
    Amministratore
    St James's House
    Charlotte Street
    M1 4DZ Manchester
    Allied Irish Bank
    United Kingdom
    United KingdomIrish147824160001
    DE BURETEL DE CHASSEY, Marc Frederic Marie
    19 Furlong Road
    N7 8LS London
    Amministratore
    19 Furlong Road
    N7 8LS London
    French110966050002
    DESSOKY, Usama
    5 Rudgwick Terrace
    20 Avenue Road
    NW8 6BR London
    Amministratore
    5 Rudgwick Terrace
    20 Avenue Road
    NW8 6BR London
    EnglandBritish85181940001
    DODD, Angus Alexander
    13 Redgrave Road
    SW15 1PX London
    Amministratore
    13 Redgrave Road
    SW15 1PX London
    British110965490001
    DUNN, Barrie
    B316 Peninsula Apartments
    4 Praed Street
    W2 1JE London
    Amministratore
    B316 Peninsula Apartments
    4 Praed Street
    W2 1JE London
    United KingdomBritish109512300001
    EDDIS, Christopher Frederick
    102 Portland Road
    Holland Park
    W11 4LX London
    Amministratore
    102 Portland Road
    Holland Park
    W11 4LX London
    United KingdomBritish59311260003
    GILLESPIE, Brendan
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    Amministratore
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    British129902710001
    GRAUERS, Clifford Eric
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    Amministratore
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    EnglandBritish60557140001
    GRAY, Robert Edward
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United KingdomBritish188584900001
    GRIFFITHS, Keith Ian
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish77782610002
    HILL, Timothy Ingram
    Monks Hollow
    Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Monks Hollow
    Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    British57283990001
    HORTHY, Sharif Istvan
    43 St Annes Crescent
    BN7 1SD Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    43 St Annes Crescent
    BN7 1SD Lewes
    East Sussex
    EnglandBritish59598440001
    INGRAM HILL, Sarah
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    British59327230001
    KINGSMILL, Robert Martin
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    Amministratore
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    United KingdomBritish139337530001
    MCKEVITT, Richard
    Nightingales Lane
    HP8 4SF Chalfont St. Giles
    Tyhurst
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Nightingales Lane
    HP8 4SF Chalfont St. Giles
    Tyhurst
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish142295770001
    MERCHANT, David John
    9 Fairmile Court
    KT11 2DS Cobham
    Surrey
    Amministratore
    9 Fairmile Court
    KT11 2DS Cobham
    Surrey
    EnglandBritish102844250001
    MITCHELL, Stephen David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    EnglandBritish95336510001
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish173110500001
    MYERS, David Paul
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish142171370001
    NOBLE, David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    EnglandBritish127359410001
    ROBINSON, Shaun
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish101627760001
    STOCKTON, Richard
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United KingdomBritish173676030001
    WHITBY, Peter James
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    EnglandEnglish76096790002
    RICKERBYS SERVICES LIMITED
    Ellenborough House
    Wellington Street
    GL50 1YD Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ellenborough House
    Wellington Street
    GL50 1YD Cheltenham
    Gloucestershire
    74346840001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    06 apr 2016
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03328699
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ATLAS HOTELS (BIRMINGHAM NT 1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2017
    Consegnato il 09 nov 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The leasehold interests in holiday inn express birmingham nec, bickenhill parkway, birmingham, west midlands, B40 1QA with title numbers WM707586 and WM900691 and, where the context so requires, the buildings on the property.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Cbre Loan Services Limited
    Transazioni
    • 09 nov 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 giu 2016
    Consegnato il 30 giu 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The leasehold interests in holiday inn express birmingham nec, bickenhill parkway, birmingham, west midlands, B40 1QA with title numbers WM707586 and WM900691, and, where the context so requires, includes the buildings on the property.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 30 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 dic 2014
    Consegnato il 19 dic 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Title number WM707586.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transazioni
    • 19 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 ott 2007
    Consegnato il 19 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties listed in schedule 2 of T. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 nov 2005
    Consegnato il 05 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land lying on the west side of redbridge lane mursling southampton t/no HP581790,land lying to the north of hyde road gorton manchester t/no GM821643,land at harbledown canterbury t/no K787140 (for details of further properties charged plea. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mag 2003
    Consegnato il 13 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from ingram hotels limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a express by holiday inn bickenhill parkway birmingham t/n WM707586. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mag 2003
    Consegnato il 13 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0