ROMARK ESTATES LIMITED

ROMARK ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROMARK ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03482380
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ROMARK ESTATES LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova ROMARK ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Critchleys Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROMARK ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ROMARK ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da The Coach House Thames Street Wallingford Oxfordshire OX10 0BH a C/O Critchleys Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP in data 21 gen 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 dic 2018

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 034823800010 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2018

    8 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2016 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2016

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    21 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Bilancio annuale redatto al 16 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 gen 2016

    Stato del capitale al 22 gen 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2015

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ROMARK ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TYRRELL, Jenny Anne
    The Coach House Thames Street
    OX10 0BH Wallingford
    Oxfordshire
    Segretario
    The Coach House Thames Street
    OX10 0BH Wallingford
    Oxfordshire
    British55734910001
    TYRRELL, Barry Clive
    The Coach House Thames Street
    OX10 0BH Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Coach House Thames Street
    OX10 0BH Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritish55734870002
    ASHBURTON REGISTRARS LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Segretario nominato
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014760001
    AR NOMINEES LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Amministratore delegato nominato
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014750001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ROMARK ESTATES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Barry Clive Tyrrell
    Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    C/O Critchleys
    06 apr 2016
    Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    C/O Critchleys
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.
    Mrs Jenny Anne Tyrrell
    Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    C/O Critchleys
    06 apr 2016
    Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    C/O Critchleys
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    ROMARK ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2014
    Consegnato il 14 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Grange farm shipton lee quainton bucks t/no.BM369695.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 27 nov 2009
    Consegnato il 17 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Blankstones farm 39 acre end street eynsham witney oxfordshire t/no ON127861 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 ott 2009
    Consegnato il 16 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 nov 2005
    Consegnato il 03 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land with the buildings thereon k/a church farm barns, aldworth road, compton, newbury, berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge of deposit
    Creato il 05 set 2005
    Consegnato il 10 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 66519969 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 lug 2005
    Consegnato il 20 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property - the manor house, 2-3 high street, highworth, swindon t/no WT219121. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 22 dic 2003
    Consegnato il 09 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    17 brigham road reading berkshire fixed charge over all rental income and the proceeds of sale of any lease of the property. Floating charge over the undertaking all property assets and rights of the company.
    Persone aventi diritto
    • Capital Home Loans Limited
    Transazioni
    • 09 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mag 2000
    Consegnato il 31 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as sandford park hotel 81/83 bath road cheltenham gloucestershire; t/no GR226703. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mag 2000
    Consegnato il 30 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as eton lodge the park cheltenham gloucestershire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 02 feb 1999
    Consegnato il 10 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a stanhope house 15 queens road cheltenham gloucestershire t/n GR210805. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    ROMARK ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 dic 2018Inizio della liquidazione
    23 gen 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Milan Vuceljic
    Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire
    Praticante
    Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire
    Lawrence John King
    Critchleys Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire
    Praticante
    Critchleys Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0