PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED

PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03483521
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 1 & 2 Sawmills End
    Barnwood
    Gloucester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2016
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 nov 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    26 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 dic 2015

    Stato del capitale al 15 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Building C Imperial Gate Business Park Corinium Avenue Barnwood Gloucester GL4 3HX a Unit 1 & 2 Sawmills End Barnwood Gloucester in data 02 dic 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    20 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 set 2015

    • Capitale: GBP 5,706,466.00
    4 pagineSH01

    Stato del capitale al 24 set 2015

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Nomina di Mr Joseph Scott Etzler come amministratore in data 01 apr 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Todd Brian Strubbe come amministratore in data 01 apr 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Jan Dutton Madsen come amministratore in data 01 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Michael Mendlik come amministratore in data 01 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 dic 2014

    Stato del capitale al 02 dic 2014

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 dic 2013

    Stato del capitale al 12 dic 2013

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MUSSMAN, David Charles
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Segretario
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    British159231890001
    BARKER, Thomas Bernard
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Amministratore
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    UsaAmericanCompany Director93201870005
    BERGER, Nancee Renee
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Amministratore
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    UsaAmericanCompany Director118155860002
    ETZLER, Joseph Scott
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    Amministratore
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    UsaAmericanPresident197073400001
    MADSEN, Jan Dutton
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    Amministratore
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    United StatesAmericanChief Financial Officer195930650001
    BHULLAR, Ujjal Simon
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director24910480002
    BROOK, John Anthony
    2 Coggan Way
    Bishopthorpe
    YO23 2QX York
    Segretario
    2 Coggan Way
    Bishopthorpe
    YO23 2QX York
    British38922990001
    SUTTON, Kirsty Jayne
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant116029280003
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BHULLAR, Amardip Singh
    4 Fern Croft
    Scarcroft
    LS14 3JN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Fern Croft
    Scarcroft
    LS14 3JN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director64136800004
    BHULLAR, Ujjal Simon
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director24910480002
    GILLINGWATER, Geoffrey Andrew
    285 Woodfield Road
    Bilton
    HG1 4JQ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    285 Woodfield Road
    Bilton
    HG1 4JQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishTechnical Director74374740001
    KELLY, Lee
    60 Nab Wood Road
    BD18 4AG Shipley
    Amministratore
    60 Nab Wood Road
    BD18 4AG Shipley
    EnglandBritishDirector116161820001
    LINFOOT, Kevin William
    Bishopthorpe Garth
    Sim Balk Lane Bishopthorpe
    YO23 2UE York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Bishopthorpe Garth
    Sim Balk Lane Bishopthorpe
    YO23 2UE York
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector51219600001
    MAY, Neil Alistair
    Orchard Spring
    Ripley Road
    HG5 9BY Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Orchard Spring
    Ripley Road
    HG5 9BY Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector116016450001
    MENDLIK, Paul Michael
    Miracle Hills Drive
    68154 Omaha
    11808
    Nebraska
    Usa
    Amministratore
    Miracle Hills Drive
    68154 Omaha
    11808
    Nebraska
    Usa
    UsaUsaDirector166934630001
    PATTON, Stephen Francis
    Laurel Bank
    32 Whitsbury Road
    SP6 1JZ Fordingbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Laurel Bank
    32 Whitsbury Road
    SP6 1JZ Fordingbridge
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director109947090001
    PICKETS, Gavin
    41 Old Pasture Road
    Frimley
    GU16 5RT Camberley
    Surrey
    Amministratore
    41 Old Pasture Road
    Frimley
    GU16 5RT Camberley
    Surrey
    BritishSales70978960001
    RAWLES, Graham Alan
    80 Robin Hood Way
    RG41 5JN Winnersh
    Berkshire
    Amministratore
    80 Robin Hood Way
    RG41 5JN Winnersh
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director97834150001
    ROBINSON, Niklas Robert
    3 Ullswater Drive
    LS22 6YF Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Ullswater Drive
    LS22 6YF Wetherby
    West Yorkshire
    EnglishOperations Director52615960001
    SMALLPAGE, Paul
    Maryland House 5 Grosvenor Road
    LS6 2DZ Leeds
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Maryland House 5 Grosvenor Road
    LS6 2DZ Leeds
    2
    United Kingdom
    BritishSales Director131580370001
    STRUBBE, Todd Brian
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Amministratore
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    UsaAmericanCompany Director159232530001
    SUTTON, Kirsty Jayne
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant116029280003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sawmills End
    Barnwood
    GL4 3DL Gloucester
    Unit 1 & 2
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Sawmills End
    Barnwood
    GL4 3DL Gloucester
    Unit 1 & 2
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02775270
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 01 ago 2006
    Consegnato il 16 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £200,000 credited to account designation number 33565147 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 lug 2006
    Consegnato il 21 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dwco 6 limited to the outgoing vendors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ujjal Simon Bhullar
    Transazioni
    • 21 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 lug 2006
    Consegnato il 18 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 18 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 20 feb 2001
    Consegnato il 24 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed and the lease dated 9TH december 1998 (as defined)
    Brevi particolari
    A first equitable charge over the deposit balance (as defined) of £5750 paid into the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • St.Martins Property Investments Limited
    Transazioni
    • 24 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 nov 1999
    Consegnato il 06 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0