BRAITRIM HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BRAITRIM HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03484688 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRAITRIM HOLDINGS LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova BRAITRIM HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Central Working White City Translation And Innovation Hub 80 Wood Lane W12 0BZ London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BRAITRIM HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BRAITRIM INVESTMENT LIMITED | 11 mar 1998 | 11 mar 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRAITRIM HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per BRAITRIM HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Braitrim House 98 Victoria Road London NW10 6NB a Central Working White City Translation and Innovation Hub 80 Wood Lane London W12 0BZ in data 10 gen 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 6Th Floor 10 Dominion Street London Uk EC2M 2EE United Kingdom a Braitrim House 98 Victoria Road London NW10 6NB | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Braitrim House 98 Victoria Road London NW10 6NB | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Graeme Andrew Scott Rutherford il 03 mar 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Director Ben James Hunt come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Ente come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joseph Murphy come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 03 lug 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BRAITRIM HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNT, Ben James, Director | Amministratore | Translation And Innovation Hub 80 Wood Lane W12 0BZ London Central Working White City England | Hong Kong | British | 183078810001 | |||||
| RUTHERFORD, Graeme Andrew Scott | Amministratore | Translation And Innovation Hub 80 Wood Lane W12 0BZ London Central Working White City England | England | British | 137560120005 | |||||
| BLANCHARD, Jonathan Neil | Segretario | 1 Little Gaddesden House Little Gaddesden HP4 1PL Berkhamsted Hertfordshire | British | 67243220003 | ||||||
| BONGIORNO, John Joseph | Segretario | 19a Selborne Road 3142 Toorak 3142 Victoria Australia | Australian | 94637000002 | ||||||
| CARSTENS, Andre | Segretario | Callantina Road 3122 Hawthorn 17 Victoria Australia | Australian | 122830070002 | ||||||
| DONEGAN, Steven Michael | Segretario | Fitzgibbon Crescent 3161 Caulfield North 28 Victoria Australia | Australian | 137561570001 | ||||||
| GIVONI, Michael Nathan | Segretario | Unit 2/6a St Leonard's Avenue 3182 St Kilda 3182 Australia | Australian | 122829370001 | ||||||
| MCDONALD, Wayne Douglas | Segretario | 13 Balfour Street Doncaster Victoria 3108 Australia | Australian | 94637090001 | ||||||
| MONTEITH, James Henry George | Segretario | 145 Rosendale Road Dulwich SE21 8HE London | British | 103511470001 | ||||||
| O'SULLIVAN, Judith-Anne | Segretario | Level 3, 350 Queen St Melbourne Victoria 3000 Australia | British | 95244390004 | ||||||
| UNITE, Roger William | Segretario | 19 Bolton Gardens TW11 9AX Teddington Middlesex | British | 57486240001 | ||||||
| SISEC LIMITED | Segretario nominato | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||
| ALLEN, Frank John | Amministratore | Kevali 13 Jeffries Court Hedsor Road SL8 5DY Bourne End Buckinghamshire | British | 42023240003 | ||||||
| BLANCHARD, Jonathan Neil | Amministratore | 1 Little Gaddesden House Little Gaddesden HP4 1PL Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 67243220003 | |||||
| BLYTHE, Brian Stuart | Amministratore | 3568 Point Nepean Road Portsea Victoria 3944 Australia | Australian | 94637020001 | ||||||
| BONGIORNO, John Joseph | Amministratore | 19a Selborne Road 3142 Toorak 3142 Victoria Australia | Australian | 94637000002 | ||||||
| CARSTENS, Andre | Amministratore | Callantina Road 3122 Hawthorn 17 Victoria Australia | Australia | Australian | 122830070002 | |||||
| COLEMAN, John Ashley | Amministratore | Everington House Everington Hill RG18 0UD Yattendon Berkshire | England | British | 62128080003 | |||||
| COOK, Lynne Yvonne | Amministratore | 148 Evelyn Avenue HA4 0EP Ruislip Middlesex | British | 69384290002 | ||||||
| DAVIDSON, Steven | Amministratore | Hollyhurst Sandy Lane KT20 6NE Tadworth Surrey | England | English | 150579140001 | |||||
| DIBDEN, Lindsay George | Amministratore | Baigens GU34 1SL Chawton Alton Hampshire | British | 40399480002 | ||||||
| ENTE, Nicholas Johan | Amministratore | Braitrim House 98 Victoria Road NW10 6NB London | Australia | Australian | 168888010001 | |||||
| ENTE, Nicholas Johan | Amministratore | Pacific Place 88 Queensway Amiralty Apt 2500 Hong Kong | Hong Kong | Australian | 137561470003 | |||||
| EVANS, Ronald Barry | Amministratore | Apartment 11 Cairns Apartments 131 Hotham Street East Melbourne Victoria 3002 Australia | Australian | 94637070001 | ||||||
| FARNIK, Josef Peter | Amministratore | Garden Street 3141 South Yarra 44 Victoria Australia | Australia | Australian | 123638990003 | |||||
| FEIST, Roger | Amministratore | Thornacre Lodge EN5 3JZ Barnet Road Hertfordshire | British | 72466200001 | ||||||
| FEIST, Roger | Amministratore | Thornacre Lodge EN5 3JZ Barnet Road Hertfordshire | British | 72466200001 | ||||||
| GLYNN, Barry Allan | Amministratore | New House 32 New Road Digswell AL6 0AH Welwyn Hertfordshire | British | 28968220001 | ||||||
| MARTIN, Nicholas Rupert Zelenka | Amministratore | 123 Mallinson Road SW11 1BH London | British | 23175310002 | ||||||
| MONTEITH, James Henry George | Amministratore | 145 Rosendale Road Dulwich SE21 8HE London | England | British | 103511470001 | |||||
| MOORE, Peter Augustine | Amministratore | Orchards Milton Bryan MK17 9HS Milton Keynes Bedfordshire | British | 39904050001 | ||||||
| MURPHY, Joseph | Amministratore | Stuyvestant Circle East Setauket 1 New York United States Of America | Usa | American | 137559970001 | |||||
| NICHOLSON, Maurice Raymond Lawrence | Amministratore | 41 Polygon Road St Heliers Auckland New Zealand | New Zealander | 107215540001 | ||||||
| PADDISON, Jack Thomas Russell | Amministratore | Not Applicable 148 Evelyn Avenue HA4 8AA Ruislip Middlesex | British | 49157890003 | ||||||
| SHALSON, Peter | Amministratore | 26 Upper Brook Street W1K 7QE London | Great Britain | British | 76379940001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BRAITRIM HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Graeme Andrew Scott Rutherford | 06 apr 2016 | Translation And Innovation Hub 80 Wood Lane W12 0BZ London Central Working White City England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
BRAITRIM HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Creato il 08 mag 1998 Consegnato il 19 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and the secured parties under the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari 1530 ord shares of $1 held by the chargor in the capital of the company with all the chargor's present and future rights including all securities all allotments all repayments all dividends. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 13 mar 1998 Consegnato il 21 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee as agent and security trustee for itself and each of the secured parties (as defined) under the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0