INGLEBY (1045) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | INGLEBY (1045) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03485429 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di INGLEBY (1045) LIMITED?
- (7222) /
Dove si trova INGLEBY (1045) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 6th Floor 4 Grosvenor Place SW1X 7DL London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di INGLEBY (1045) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| VERTEX LIMITED | 27 giu 2008 | 27 giu 2008 |
| INGLEBY (1045) LIMITED | 24 dic 1997 | 24 dic 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di INGLEBY (1045) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per INGLEBY (1045) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Paul Terence Sweeny il 17 dic 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 6 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 6 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 6 pagine | MG02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Pegasus House Kings Business Park Liverpool Road Prescot Merseyside L34 1PJ in data 26 ago 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 dic 2009 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey Chittenden come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey Chittenden come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed vertex LIMITED\certificate issued on 13/01/09 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
legacy | 5 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2008 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di INGLEBY (1045) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEFFIELD, Anne Louise | Segretario | Flat 15 The Design Works 93-99 Goswell Road EC1V 7EY London | British | 85634660002 | ||||||
| JAMES, Gavin Keith, Mr. | Amministratore | Camelford Bradcutts Lane SL6 9AA Cookham Dean Berkshire | England | British | 44173560008 | |||||
| SWEENY, Paul Terence | Amministratore | 98 Park Street W1K 6NZ London Flat 4 United Kingdom | United Kingdom | British | 140303320002 | |||||
| AMOS, David Stephen | Segretario | 6 Acre Lane Webheath B97 5WN Redditch Worcestershire | British | 65186080003 | ||||||
| BIRKETT, Timothy Lloyd | Segretario | 17 Padstow Drive Bramhall SK7 2HU Stockport Cheshire | British | 99698140001 | ||||||
| CROFT, Christopher Rendell | Segretario | 2 Grimston Road SW6 3QP London | British | 55143000001 | ||||||
| FRITCHIE, Andrew Peel | Segretario | Orchard House Beckford Hall Beckford GL20 7AA Tewkesbury Gloucestershire | British | 79149580001 | ||||||
| THOMAS, Stephen Jeremy | Segretario | Willow Cottage Hill End Twyning GL20 6DW Tewkesbury Gloucestershire | British | 97303290001 | ||||||
| WHITMORE, Gerald Michael | Segretario | 18 The Woodlands Pedmore DY8 2RA Stourbridge West Midlands | British | 41061870001 | ||||||
| INGLEBY NOMINEES LIMITED | Segretario nominato | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
| UU SECRETARIAT LIMITED | Segretario | Haweswater House, Lingley Mere Business Park Lingley Green Avenue Great Sankey WA5 3LP Warrington | 94063410003 | |||||||
| AMOS, David Stephen | Amministratore | 6 Acre Lane Webheath B97 5WN Redditch Worcestershire | British | 65186080003 | ||||||
| BEVERIDGE, Robert James | Amministratore | 81 Kidmore Road Caversham RG4 7NQ Reading | United Kingdom | British | 62452090001 | |||||
| BROWN, Neil Graeme | Amministratore | 2 Aldenham Avenue WD7 8HJ Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 49772410001 | |||||
| CHITTENDEN, Jeffrey George John | Amministratore | 11 Sheldon Square W2 6DQ London Apartment 68 | United Kingdom | British | 123115670003 | |||||
| DRURY, Thomas Waterworth | Amministratore | Legh Cottage Legh Road WA16 8LS Knutsford Cheshire | United Kingdom | British/Canadian | 29701240002 | |||||
| FRITCHIE, Andrew Peel | Amministratore | Orchard House Beckford Hall Beckford GL20 7AA Tewkesbury Gloucestershire | England | British | 79149580001 | |||||
| GALES, David Robert | Amministratore | 4 The Pavillions End GU15 2LD Camberley Surrey | British | 22498240002 | ||||||
| GITTINS, John Anthony | Amministratore | East Wing Leighton House Leighton Road Neston CH64 3SW Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 164311370001 | |||||
| GRAHAM, Richard Halton | Amministratore | 307 Sunup Holiday Park Ellicottville 1473196 New York New York 14731-9604 Usa | Canadian | 120665310001 | ||||||
| GREEN, Stephen Nathaniel | Amministratore | 9 Woodcocks TN27 9HB Headcorn Kent | British | 62499540001 | ||||||
| HUNT, Andrew James | Amministratore | Millswood Old Neighbouring, Chalford GL6 8AA Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 54503850003 | |||||
| JONES, Martin Peter William | Amministratore | The Mews Cottage Cranbourne Grange Hatchet Lane Cranbourne SL4 4RH Ascot Berkshire | British | 15332330002 | ||||||
| SHEPHERD, Dale Stanley | Amministratore | 1004 Shenandoah Road IRISH Lexington Virginia 24450 Usa | American | 124135650001 | ||||||
| SYMONDS, Christine Ann | Amministratore | Ryde House, 5 The Woodlands Pedmore DY8 2RA Stourbridge West Midlands | British | 24999120002 | ||||||
| THOMAS, Stephen Jeremy | Amministratore | Willow Cottage Hill End Twyning GL20 6DW Tewkesbury Gloucestershire | British | 97303290001 | ||||||
| WHITMORE, Gerald Michael | Amministratore | Appletrees Church Street WR10 2JD Wyre Piddle Worcestershire | United Kingdom | British | 41061870002 | |||||
| INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
INGLEBY (1045) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 07 dic 1998 Consegnato il 24 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan note instrument constituting £10,422,500 9% secured loan notes together with interest and any other monies incurred by the security agent or any noteholder in relation to the debenture | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture to secure 9% £4,986,000 fixed rate "b" loan notes | Creato il 07 dic 1998 Consegnato il 16 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the instrument of even date and all other sums due under this debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture to secure 9% £1,632,000 fixed rate "c" loan notes | Creato il 07 dic 1998 Consegnato il 16 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the instrument of even date and all other sums due under this debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities | Creato il 07 dic 1998 Consegnato il 10 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 36,495 a ordinary shares of £1. 729,900 10P a ordinary shares & 13,505 b ordinary shares of £1 in the capital of crisp computing limited and all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 07 dic 1998 Consegnato il 10 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from ingleby (1045) limited and crisp computing limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0