INGLEBY (1045) LIMITED

INGLEBY (1045) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINGLEBY (1045) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03485429
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INGLEBY (1045) LIMITED?

    • (7222) /

    Dove si trova INGLEBY (1045) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6th Floor 4 Grosvenor Place
    SW1X 7DL London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INGLEBY (1045) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VERTEX LIMITED27 giu 200827 giu 2008
    INGLEBY (1045) LIMITED24 dic 199724 dic 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di INGLEBY (1045) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per INGLEBY (1045) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 24 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2011

    Stato del capitale al 06 gen 2011

    • Capitale: GBP 21,186.94
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Terence Sweeny il 17 dic 2010

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    6 pagineMG02

    legacy

    6 pagineMG02

    legacy

    6 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    6 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Indirizzo della sede legale modificato da Pegasus House Kings Business Park Liverpool Road Prescot Merseyside L34 1PJ in data 26 ago 2010

    1 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 24 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Jeffrey Chittenden come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeffrey Chittenden come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    2 pagine288a

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed vertex LIMITED\certificate issued on 13/01/09
    2 pagineCERTNM

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di INGLEBY (1045) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHEFFIELD, Anne Louise
    Flat 15 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7EY London
    Segretario
    Flat 15 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7EY London
    British85634660002
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish44173560008
    SWEENY, Paul Terence
    98 Park Street
    W1K 6NZ London
    Flat 4
    United Kingdom
    Amministratore
    98 Park Street
    W1K 6NZ London
    Flat 4
    United Kingdom
    United KingdomBritish140303320002
    AMOS, David Stephen
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    British65186080003
    BIRKETT, Timothy Lloyd
    17 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    Segretario
    17 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    British99698140001
    CROFT, Christopher Rendell
    2 Grimston Road
    SW6 3QP London
    Segretario
    2 Grimston Road
    SW6 3QP London
    British55143000001
    FRITCHIE, Andrew Peel
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    Segretario
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    British79149580001
    THOMAS, Stephen Jeremy
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    Segretario
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    British97303290001
    WHITMORE, Gerald Michael
    18 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    18 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    British41061870001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Segretario nominato
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    UU SECRETARIAT LIMITED
    Haweswater House, Lingley Mere Business Park
    Lingley Green Avenue Great Sankey
    WA5 3LP Warrington
    Segretario
    Haweswater House, Lingley Mere Business Park
    Lingley Green Avenue Great Sankey
    WA5 3LP Warrington
    94063410003
    AMOS, David Stephen
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    British65186080003
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    Amministratore
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritish62452090001
    BROWN, Neil Graeme
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish49772410001
    CHITTENDEN, Jeffrey George John
    11 Sheldon Square
    W2 6DQ London
    Apartment 68
    Amministratore
    11 Sheldon Square
    W2 6DQ London
    Apartment 68
    United KingdomBritish123115670003
    DRURY, Thomas Waterworth
    Legh Cottage
    Legh Road
    WA16 8LS Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Legh Cottage
    Legh Road
    WA16 8LS Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish/Canadian29701240002
    FRITCHIE, Andrew Peel
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish79149580001
    GALES, David Robert
    4 The Pavillions End
    GU15 2LD Camberley
    Surrey
    Amministratore
    4 The Pavillions End
    GU15 2LD Camberley
    Surrey
    British22498240002
    GITTINS, John Anthony
    East Wing Leighton House
    Leighton Road Neston
    CH64 3SW Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    East Wing Leighton House
    Leighton Road Neston
    CH64 3SW Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish164311370001
    GRAHAM, Richard Halton
    307 Sunup Holiday Park
    Ellicottville
    1473196 New York
    New York 14731-9604
    Usa
    Amministratore
    307 Sunup Holiday Park
    Ellicottville
    1473196 New York
    New York 14731-9604
    Usa
    Canadian120665310001
    GREEN, Stephen Nathaniel
    9 Woodcocks
    TN27 9HB Headcorn
    Kent
    Amministratore
    9 Woodcocks
    TN27 9HB Headcorn
    Kent
    British62499540001
    HUNT, Andrew James
    Millswood
    Old Neighbouring, Chalford
    GL6 8AA Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Millswood
    Old Neighbouring, Chalford
    GL6 8AA Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish54503850003
    JONES, Martin Peter William
    The Mews Cottage Cranbourne Grange
    Hatchet Lane Cranbourne
    SL4 4RH Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    The Mews Cottage Cranbourne Grange
    Hatchet Lane Cranbourne
    SL4 4RH Ascot
    Berkshire
    British15332330002
    SHEPHERD, Dale Stanley
    1004 Shenandoah Road
    IRISH Lexington
    Virginia 24450
    Usa
    Amministratore
    1004 Shenandoah Road
    IRISH Lexington
    Virginia 24450
    Usa
    American124135650001
    SYMONDS, Christine Ann
    Ryde House, 5 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Ryde House, 5 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    British24999120002
    THOMAS, Stephen Jeremy
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    British97303290001
    WHITMORE, Gerald Michael
    Appletrees
    Church Street
    WR10 2JD Wyre Piddle
    Worcestershire
    Amministratore
    Appletrees
    Church Street
    WR10 2JD Wyre Piddle
    Worcestershire
    United KingdomBritish41061870002
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Amministratore delegato nominato
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    INGLEBY (1045) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 24 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan note instrument constituting £10,422,500 9% secured loan notes together with interest and any other monies incurred by the security agent or any noteholder in relation to the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Apax Partners & Co. Ventures(As Security Agent for Itself and the Noteholders)
    Transazioni
    • 24 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture to secure 9% £4,986,000 fixed rate "b" loan notes
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 16 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the instrument of even date and all other sums due under this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gerald Michael Whitmore,as Security Agent for Himself and the Noteholders (As Defined in Thedebenture)
    Transazioni
    • 16 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture to secure 9% £1,632,000 fixed rate "c" loan notes
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 16 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the instrument of even date and all other sums due under this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Christine Ann Symonds,as Security Agent for Herself and the Noteholders (As Defined in Thedebenture)
    Transazioni
    • 16 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 10 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    36,495 a ordinary shares of £1. 729,900 10P a ordinary shares & 13,505 b ordinary shares of £1 in the capital of crisp computing limited and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 10 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from ingleby (1045) limited and crisp computing limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0