PRL REALISATIONS 1 LIMITED

PRL REALISATIONS 1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRL REALISATIONS 1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03485614
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRL REALISATIONS 1 LIMITED?

    • Attività delle agenzie di lavoro interinale (78200) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PRL REALISATIONS 1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Uk
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PRL REALISATIONS 1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PMP RECRUITMENT LIMITED24 dic 199724 dic 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRL REALISATIONS 1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per PRL REALISATIONS 1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    22 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Cessazione della carica di Jack Rainer Ullmann come amministratore in data 12 mar 2021

    1 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    39 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    37 pagineAM10

    Indirizzo della sede legale modificato da Chevron House Long Lane Hillingdon Uxbridge Middlesex UB10 9PF England a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds Uk LS1 4DL in data 13 lug 2020

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 15 apr 2020

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    19 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    4 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    59 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    4 pagineAM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 02 mar 2020

    RES15

    Cessazione della carica di Alan Connor come segretario in data 05 mar 2020

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Chris Martin Kenneally come amministratore in data 05 mar 2020

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 034856140018 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 034856140021, creata il 14 feb 2020

    9 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 034856140022, creata il 14 feb 2020

    9 pagineMR01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 27 dic 2018 al 26 dic 2018

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Cordant Security Chevron House Long Lane Hillingdon Uxbridge Middlesex UB10 9PF England a Chevron House Long Lane Hillingdon Uxbridge Middlesex UB10 9PF in data 08 ott 2019

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di PRL REALISATIONS 1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ULLMANN, Phillip Lionel
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Uk
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Uk
    EnglandBritishGroup Managing46458480002
    CONNOR, Alan
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    Middlesex
    England
    Segretario
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    Middlesex
    England
    BritishDirector118003220001
    GARRATT, Mark Jonathan
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    Segretario
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    BritishDirector118003050001
    JOHNSON, Julia Elizabeth
    3 Grenfell Avenue
    SL6 1HQ Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    3 Grenfell Avenue
    SL6 1HQ Maidenhead
    Berkshire
    BritishRecruitment54702040001
    MANLEY, Nicholas Mark
    Jupiter
    7 Mortens Wood
    HP7 9EQ Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    Jupiter
    7 Mortens Wood
    HP7 9EQ Amersham
    Buckinghamshire
    British60380830002
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Segretario nominato
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    DISKIN, Mark
    Coachmans Cottage Rose Hill
    SL1 8NN Burnham
    Berkshire
    Amministratore
    Coachmans Cottage Rose Hill
    SL1 8NN Burnham
    Berkshire
    South AfricaSouth AfricanDirector2953170001
    GARRATT, Mark Jonathan
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    Amministratore
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    EnglandBritishCompany Director118003050001
    JOHNSON, Julia Elizabeth
    118 Grenfell Road
    SL6 1HD Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    118 Grenfell Road
    SL6 1HD Maidenhead
    Berkshire
    BritishRecruitment54702040002
    KENNEALLY, Chris Martin
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    Middlesex
    England
    WalesBritishDirector267876240001
    KIRKPATRICK, Steven William
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Northern IrelandNorthern IrishDirector185295780002
    LEWIS, Andrew George
    217 Turnpike Drive
    LU3 3RD Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    217 Turnpike Drive
    LU3 3RD Luton
    Bedfordshire
    BritishRecruitment Consultant69510470002
    MANLEY, Nicholas Mark
    Jupiter
    7 Mortens Wood
    HP7 9EQ Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Jupiter
    7 Mortens Wood
    HP7 9EQ Amersham
    Buckinghamshire
    BritishAccountant60380830002
    PERCIVAL, Lorraine Elizabeth
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director85413680001
    SKELTON, Derek
    Whittlewood 6b Cattle End
    Silverstone
    NN12 8UX Towcester
    Amministratore
    Whittlewood 6b Cattle End
    Silverstone
    NN12 8UX Towcester
    BritishRecruitment Consultant45587610004
    TILLER, Russell John Ernest
    Braeside
    North Road
    HP15 6NE Widmer End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Braeside
    North Road
    HP15 6NE Widmer End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector4770810002
    ULLMANN, Jack Rainer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Uk
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Uk
    EnglandBritishDirector11342820001
    ULLMANN, Marianne Flora
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritishDirector6228260001
    WARREN, Terence George
    19 Saint Andrews Crescent
    SL4 4EW Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    19 Saint Andrews Crescent
    SL4 4EW Windsor
    Berkshire
    EnglandBritishManaging Director31018120001
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PRL REALISATIONS 1 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Kelly Kendall
    55-57 Sheep Street
    NN1 2NE Northampton
    Oriel House
    England
    06 apr 2016
    55-57 Sheep Street
    NN1 2NE Northampton
    Oriel House
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Jamie Reynolds
    346 Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    England
    06 apr 2016
    346 Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Cordant People Limited
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    346
    England
    06 apr 2016
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    346
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione02636670
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    PRL REALISATIONS 1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 feb 2020
    Consegnato il 18 feb 2020
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 14 feb 2020
    Consegnato il 18 feb 2020
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 18 feb 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 ago 2016
    Consegnato il 15 ago 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Centrovalli LTD
    Transazioni
    • 15 ago 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 mag 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2016
    Consegnato il 07 giu 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 3 of the guarantee and fixed and floating charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 mag 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 18 gen 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 03 mar 2014
    Consegnato il 10 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 mag 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 18 gen 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 21 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 28 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 28 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 mag 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 18 gen 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 mag 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 18 gen 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A supplemental debenture
    Creato il 05 ago 2009
    Consegnato il 14 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Confirmatory deed
    Creato il 17 apr 2009
    Consegnato il 01 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and from the chargors to rbs invoice finance limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Offices at the rear of 29-35 (odd) cowgate peterborough t/no CB117005, 35 and 37 wellington street luton t/no BD130001, 168 high street scunthorpe t/no HS308352 and 1 hazelwood road northampton t/no NN114873; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 14 giu 2007
    Consegnato il 25 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment
    Creato il 05 feb 2007
    Consegnato il 16 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the assignors rights, titles and interest in and to the panther acquisition agreement.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (C/O the Royal Bank of Scotland PLC)
    Transazioni
    • 16 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 set 2006
    Consegnato il 25 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Offices at the rear of 29-35 (odd) cowgate peterborough, 35-37 wellington street luton, 168 high street scunthorpe, for details of further property charged please refer to form 395, with fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 ago 2006
    Consegnato il 04 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 04 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 apr 2006
    Consegnato il 16 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 2006
    Consegnato il 04 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H 168 high street scunthorpe t/n HS308352. F/h 35 and 37 wellington street luton t/n BD130001. F/h 1 hazelwood road northampton t/n NN114873. F/h land at rear of 29-35 cowgate peterborough (car park) t/n CB117005.
    Persone aventi diritto
    • Clifton Holding Inc Richard Thomas Peter Upton Susan Warren and Terrence Warren Jointly Astrustees for and on Behalf of the Warren FAMILY1998 Settlement. for Further Details of Mortgagees Please Refer to Form 395
    Transazioni
    • 04 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    35-37 wellington street luton bedfordshire bd 130001. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 11 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    168 high street scunthorpe. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 ago 2002
    Consegnato il 15 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h land being 1 hazelwood road northampton northants t/n NN114873. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 giu 2001
    Consegnato il 21 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as 35-37 wellington st,luton,beds LU1 2QH; BD130001. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 feb 2001
    Consegnato il 02 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 20 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Credit Services Limited
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 apr 1998
    Consegnato il 09 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PRL REALISATIONS 1 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 mar 2020Inizio dell'amministrazione
    08 mar 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Rachael Wilkinson
    3 Forbury Place 23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire
    Praticante
    3 Forbury Place 23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0