OLD FORD HOUSING ASSOCIATION

OLD FORD HOUSING ASSOCIATION

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOLD FORD HOUSING ASSOCIATION
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 03487210
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    Indirizzo della sede legale
    Two Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Varie

    Forms b and z convert to rs
    2 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to rs 19/09/2016
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 dic 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Clare Miller come segretario in data 29 nov 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Paul Pearce come amministratore in data 19 dic 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Angela Marie Drum come segretario in data 29 nov 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    58 pagineAA

    Nomina di Mr Simon Charles Trevor Fowler come amministratore in data 25 feb 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Duncan Shrubsole come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Rolf Wojtanowski come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Angela Marie Drum come segretario in data 01 feb 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Deborah Upton come segretario in data 31 gen 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 22 dic 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Rolf Wojtanowski come amministratore in data 11 gen 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Pearce il 02 feb 2015

    2 pagineCH01

    Nomina di Mrs Jacqueline Harris come amministratore in data 10 feb 2010

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Marc Francis il 02 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jennifer Ann Dearing il 02 feb 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Michael John Armstrong come amministratore in data 22 mar 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del segretario cambiati per Deborah Upton il 02 feb 2015

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    47 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Circle House 1-3 Highbury Station Road London N1 1SE a Two Pancras Square King's Cross London N1C 4AG in data 19 feb 2015

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 22 dic 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    7 pagineAR01

    Nomina di Mr Stephen Melvyn Edward Jacobs Obe come amministratore in data 23 set 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    46 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MILLER, Clare
    More London Place
    SE1 2DA London
    Level 6, 6 More London Place
    England
    Segretario
    More London Place
    SE1 2DA London
    Level 6, 6 More London Place
    England
    221705990001
    DEARING, Jennifer Ann
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Amministratore
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    United KingdomEnglish137054520001
    FOWLER, Simon Charles Trevor
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Amministratore
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    EnglandBritish162070440001
    FRANCIS, Marc
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Amministratore
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    EnglandBritish125867050002
    HARRIS, Jacqueline
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Amministratore
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    EnglandBritish204256390001
    JACOBS, Stephen Melvyn Edward
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Amministratore
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    United KingdomBritish55934860002
    SHRUBSOLE, Duncan Owen
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Amministratore
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    EnglandBritish150091430004
    WOJTANOWSKI, Rolf
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Amministratore
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    EnglandGerman204256400001
    CARPENTER, Gillian Marie
    23 Sedgwick Road
    Leyton
    E10 6QR London
    Segretario
    23 Sedgwick Road
    Leyton
    E10 6QR London
    British18058600001
    DRUM, Angela Marie
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Segretario
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    209652440001
    FIRMAN, Angela June
    1-3 Highbury Station Road
    N1 1SE London
    Circle House
    United Kingdom
    Segretario
    1-3 Highbury Station Road
    N1 1SE London
    Circle House
    United Kingdom
    British139160540001
    SEMPLE, Kirsty
    16 Anglesea Road
    CO7 9JR Wivenhoe
    Essex
    Segretario
    16 Anglesea Road
    CO7 9JR Wivenhoe
    Essex
    British119026250001
    UPTON, Deborah
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Segretario
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    British170479580001
    WYLES, Marianne Clare
    3 Park Lane
    EN10 7NG Broxbourne
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Park Lane
    EN10 7NG Broxbourne
    Hertfordshire
    British51255500001
    ARMSTRONG, Michael John
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    Amministratore
    Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Two
    United KingdomBritish133526160001
    BERGIN, Deanne Cecile
    24 Waterlow Court
    Heath Close
    NW11 7DT London
    Amministratore
    24 Waterlow Court
    Heath Close
    NW11 7DT London
    British46391910001
    BOLTON, Lucinda Carol
    33 St Maur Road
    SW6 4DR London
    Amministratore
    33 St Maur Road
    SW6 4DR London
    British6166170001
    BOON, Debbie Jane
    1-3 Highbury Station Road
    N1 1SE London
    Circle House
    Amministratore
    1-3 Highbury Station Road
    N1 1SE London
    Circle House
    United KingdomBritish175447620001
    BRADBURY, Patricia Anne
    34 Riversdale Road
    N5 2JT London
    Amministratore
    34 Riversdale Road
    N5 2JT London
    British62198080001
    BUTCHER, David Martin
    2 Hollybush Close
    Snaresbrook
    E11 1PZ London
    Amministratore
    2 Hollybush Close
    Snaresbrook
    E11 1PZ London
    EnglandBritish91116680001
    CHOWDHURY, Shabbir Ahmed
    Mostyn Grove
    E3 2GT London
    15
    Amministratore
    Mostyn Grove
    E3 2GT London
    15
    United KingdomBritish127989930001
    CLARK, Mary Bridget
    4 Morville Street
    E3 2DG London
    Amministratore
    4 Morville Street
    E3 2DG London
    British57774230002
    DOBSON, Beverly
    24 Buckingham Road
    E18 2NJ South Woodford
    London
    Amministratore
    24 Buckingham Road
    E18 2NJ South Woodford
    London
    EnglandBritish90754970001
    EDDY, Colin Gonzalves
    25a Stepney Green
    Stepney Green
    E1 3JX London
    Amministratore
    25a Stepney Green
    Stepney Green
    E1 3JX London
    EnglandTrinidadian101116410001
    EDDY, Colin
    15 Deans Lane
    HA8 9HX Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    15 Deans Lane
    HA8 9HX Edgware
    Middlesex
    Citizen Of Trinidadand Tobago79901510001
    GRAHAM, Herbert
    45 Park Meadow
    AL9 5HB Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    45 Park Meadow
    AL9 5HB Hatfield
    Hertfordshire
    British29180760001
    HARRIS, Jacqueline
    3 Springwood Close
    Morville Street
    E3 2GE London
    Amministratore
    3 Springwood Close
    Morville Street
    E3 2GE London
    EnglandBritish204256390001
    HOODLESS, Donald
    Flat 10 Eclipse Building
    26 Laycock Street
    N1 1AH London
    Amministratore
    Flat 10 Eclipse Building
    26 Laycock Street
    N1 1AH London
    EnglandBritish95406030001
    JACOTINE, Clive Ivan
    54 Arbery Road
    E3 5DD London
    Amministratore
    54 Arbery Road
    E3 5DD London
    EnglandBritish53064560001
    LUCAS, Ann Patricia
    14 Sextant Avenue
    Saunders Ness Road
    E14 9DX London
    Amministratore
    14 Sextant Avenue
    Saunders Ness Road
    E14 9DX London
    United KingdomBritish57774190001
    LUDLOW, Janet
    48 Lichfield Road
    E3 5AT London
    Amministratore
    48 Lichfield Road
    E3 5AT London
    EnglandBritish21935580001
    MABEY, Robin Charles
    42 Highbury Place
    N5 1QL London
    Amministratore
    42 Highbury Place
    N5 1QL London
    British48398720001
    MATHURIN, Chantel
    Elsa Street
    E1 0NY London
    8
    Amministratore
    Elsa Street
    E1 0NY London
    8
    United KingdomBritish140834120001
    MCLAUGHLIN, Bonnie
    4 Ermine House
    Bow
    E3 2QQ London
    Amministratore
    4 Ermine House
    Bow
    E3 2QQ London
    British104330350001
    MILLER, Ray
    311 Old Ford Road
    E3 5PR London
    Amministratore
    311 Old Ford Road
    E3 5PR London
    British88159610001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per OLD FORD HOUSING ASSOCIATION?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    22 dic 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    OLD FORD HOUSING ASSOCIATION ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge
    Creato il 28 set 2010
    Consegnato il 07 ott 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor with full title guarantee as security for the paymet of all secured obligations charged in favour of the security trustee by way of first fixed charge all benefits claims and returns of permiums in respect of any insurance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 07 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    An account charge
    Creato il 17 feb 2010
    Consegnato il 05 mar 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged account and the credit balance from time to time of the charged account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Circle Anglia Social Housing PLC
    Transazioni
    • 05 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Fixed charge
    Creato il 10 set 2008
    Consegnato il 18 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as a trustee for the other secured beneficiaries) or to any of the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and any part of any estate or interest in the property being 20, 24, 30, 34, 38, 46 and 48 jodrell road; 1-76 (inc) waverton house, jodell road london; 1-76 (inc) winford house; 1-56 (inc) ollerton green; 1-62 (inc) elton house, 1-147 (odd) and 2-36 (even) candy street and 1-40 (inc) locton green, ruston street, london (formerly known as land and buildings being known as the locton estate london t/no EGL530242. 89 cadogan terrace t/no 149181. for details of further properties charged please refer to form 395. see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for the Security Beneficiaries (Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north west side of hawthorn avenue london t/no EGL446969; 25 usher road bow NGL441623; 23 usher road bow t/no EGL213595 (for further details of properties charged please refer to form 395) and all buildings, fixtures, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 12 ott 2007
    Consegnato il 18 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge the whole of the chargors undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited as Trustee for the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 18 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge
    Creato il 08 ott 2007
    Consegnato il 13 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or to any of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All property fittings fixed plant and machinery all benefits claims and returns of any insurance the benefit of all present and future licences and all income and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 13 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge
    Creato il 08 ott 2007
    Consegnato il 13 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or to any of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All property fittings fixed plant and machinery all benefits claims and returns of any insurance the benefit of all present and future licences and all income and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 13 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 16 mar 2006
    Consegnato il 22 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies du or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 22 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A fixed charge
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 13 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All property fittings fixed plant and machinery all benefits claims and returns of any insurance the benefit of all present and future licencesand all income and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 13 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An account charge
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 13 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All moneys from time to time standing to the credit of the sinking fund and the facility account and the debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent
    Transazioni
    • 13 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 04 apr 2005
    Consegnato il 22 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The whole of the chargor's undertaking and assets,present and future.
    Persone aventi diritto
    • Circle Thirty Three Housing Trust Limited
    Transazioni
    • 22 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0