MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED

MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03488633
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cannon Place
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MEDOMSLEY SECURE TRAINING SERVICES LIMITED13 mar 199813 mar 1998
    ALNERY NO. 1734 LIMITED05 gen 199805 gen 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Peter Ashbrook il 01 mag 2016

    2 pagineCH01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 01 giu 2016

    20 pagineRP04

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 giu 2016

    Stato del capitale al 06 giu 2016

    • Capitale: GBP 200,000
    SH01
    Note
    DataNota
    16 giu 2016Clarification A second filed AR01 was registered on 16/06/2016.

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 feb 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr John Ivor Cavill come amministratore in data 25 gen 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Biif Corporate Services Limited come amministratore in data 25 gen 2016

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 01 lug 2015

    1 pagineCH02

    Indirizzo della sede legale modificato da , C/O Dundas & Wilson, Northwest Wing Bush House Aldwych, London, WC2B 4EZ a Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF in data 01 lug 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 giu 2015

    Stato del capitale al 17 giu 2015

    • Capitale: GBP 200,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Peter Ashbrook il 01 set 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Philip Peter Ashbrook come amministratore in data 25 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard David Hoile come amministratore in data 25 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 giu 2014

    Stato del capitale al 18 giu 2014

    • Capitale: GBP 200,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    17 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da , C/O Dundas & Wilson, North West Wing Bush House Aldwych, London, WC2B 4EZ in data 27 ago 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05372427
    128530180002
    ASHBROOK, Philip Peter
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish121252960004
    BALDOCK, Graham
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Amministratore
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish49519600001
    CAVILL, John Ivor
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Amministratore
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    EnglandBritish152521640008
    BESWICK, Nigel Lloyd
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    Segretario
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    British56835390001
    COOKE, David John
    31 Foxborough
    Swallowfield
    RG7 1RW Reading
    Berkshire
    Segretario
    31 Foxborough
    Swallowfield
    RG7 1RW Reading
    Berkshire
    British83213800001
    MOORE, William Edmond
    35 Black Acre Close
    HP7 9EW Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    35 Black Acre Close
    HP7 9EW Amersham
    Buckinghamshire
    British114630630002
    TODD, Francesca Anne
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    Segretario
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    British72249980001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Segretario nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BAILEY, Carol Elaine
    Apt 24 Claremont Lodge
    15 The Downs
    SW20 8UA London
    Amministratore
    Apt 24 Claremont Lodge
    15 The Downs
    SW20 8UA London
    British93650840001
    BAILEY, Carol Elaine
    193 Cottenham Park Road
    SW20 0SY London
    Amministratore
    193 Cottenham Park Road
    SW20 0SY London
    EnglandBritish9905530001
    BESWICK, Nigel Lloyd
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    Amministratore
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    United KingdomBritish56835390001
    CALABRESE, Wayne Howard
    193 Ocean Key Way
    33477 Jupiter
    Florida
    Usa
    Amministratore
    193 Ocean Key Way
    33477 Jupiter
    Florida
    Usa
    United StatesAmerican30780670003
    CARTER, James Duncan
    The Slopes
    Charterhouse Road
    GU7 2AW Godalming
    Surrey
    Amministratore
    The Slopes
    Charterhouse Road
    GU7 2AW Godalming
    Surrey
    British93908800001
    CORNWELL, Anthony Bruce
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    Amministratore
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritish3471920001
    CRAWSHAW, Andrew Julian
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    Amministratore
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    EnglandBritish130322170001
    EDWARDS, Philip John
    430 Yorktown Road
    GU47 0PR Sandhurst
    Berkshire
    Amministratore
    430 Yorktown Road
    GU47 0PR Sandhurst
    Berkshire
    British87032350001
    FUTCHER, William Frank
    1 Beech Park
    HP6 6PY Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Beech Park
    HP6 6PY Amersham
    Buckinghamshire
    British51346890001
    HAGA, Thomas Justin
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    Amministratore
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    United KingdomBritish111282640001
    HAYWARD, Neil
    21 Gibbon Road
    KT2 6AD Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    21 Gibbon Road
    KT2 6AD Kingston Upon Thames
    Surrey
    British144924760001
    HILL, Gavin
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Amministratore
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    United KingdomBritish84457250005
    HOILE, Richard David
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing Bush House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing Bush House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137848430002
    JEFFERY, John Daniel Michael
    Fairpark House
    18 Green Lane
    KT11 2NN Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Fairpark House
    18 Green Lane
    KT11 2NN Cobham
    Surrey
    British93851850002
    KEENS, Donald Herbert
    7807 Ironhorse Boulevard
    West Palm Beach
    33412
    Usa
    Amministratore
    7807 Ironhorse Boulevard
    West Palm Beach
    33412
    Usa
    British70256340003
    LEACH, Guy William
    Apartment D162 Parliment View
    Apartments 1 Albert Embankment
    SE1 7XQ London
    Amministratore
    Apartment D162 Parliment View
    Apartments 1 Albert Embankment
    SE1 7XQ London
    British70877660003
    LEWIS, Kevin Tony
    36 Woodbury Road
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Amministratore
    36 Woodbury Road
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Australian86468730001
    LEWIS, Kevin Tony
    Boanti House
    Swallowfield Street
    RG7 1QX Swallowfield
    Berkshire
    Amministratore
    Boanti House
    Swallowfield Street
    RG7 1QX Swallowfield
    Berkshire
    Australian52036330001
    MCDONAGH, John
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    Amministratore
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    British116580030002
    MCNAUGHT, William Wright
    14 Church Road East
    GU14 6QJ Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    14 Church Road East
    GU14 6QJ Farnborough
    Hampshire
    British52531510002
    MEAD, Mark William
    28 The Burlings
    SL5 8BY Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    28 The Burlings
    SL5 8BY Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish151850410001
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomBritish156912990001
    REICHERTER, Matthias Alexander
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomGerman138502740001
    RIALL, Thomas Richard Phineas
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Amministratore
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    United KingdomBritish76434190002
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Amministratore
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    SMITH, John
    4 Longwater Lane
    RG40 4NZ Finchampstead
    Berkshire
    Amministratore
    4 Longwater Lane
    RG40 4NZ Finchampstead
    Berkshire
    British95897660001

    MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security assignment
    Creato il 02 dic 2006
    Consegnato il 07 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from pcfl to the security trustee and the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the company's right,title and interest,present and future,in.under and to the relevant contract. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of release and counter-indemnity
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 03 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the company's present and future rights in claims under the benefit of the deed of release in accordance with and subject to the terms and conditions of the senior charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Banks
    Transazioni
    • 03 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of release and counter-indemnity
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 03 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the company's present and future rights in claims under the benefit of the deed of release in accordance with and subject to the terms and conditions of the subordinated charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Serco Investments Limited as Subordinated Security Trustee on Behalf of the Lenders
    Transazioni
    • 03 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    A subordinated fixed and floating charge
    Creato il 12 nov 1998
    Consegnato il 27 nov 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under each or any of the financing agreements
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Serco Investments Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 27 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of fixed charge
    Creato il 12 nov 1998
    Consegnato il 20 nov 1998
    In corso
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement of even date ("the dcmf contract")
    Brevi particolari
    All the companys right title and interest in and to the equipment (as defined therein).
    Persone aventi diritto
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department
    Transazioni
    • 20 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 nov 1998
    Consegnato il 25 nov 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the agent) under each or any of the financing agreements
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0