AWT SCALES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | AWT SCALES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03492627 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AWT SCALES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova AWT SCALES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 99 Gresham Street EC2V 7NG London Uk |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di AWT SCALES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| AVERY WEIGH-TRONIX LIMITED | 19 nov 2003 | 19 nov 2003 |
| SALTER WEIGH-TRONIX LIMITED | 05 mag 1998 | 05 mag 1998 |
| SWT LIMITED | 08 apr 1998 | 08 apr 1998 |
| LAW 935 LIMITED | 14 gen 1998 | 14 gen 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di AWT SCALES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per AWT SCALES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Matthew Hudson il 21 mag 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 nov 2011 al 31 dic 2011 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2009 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Philip Matthew Deakin il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ola Tricia-Aramita Barreto-Morley il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Edward Ufland il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Giles Hudson il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per S & J Registrars Limited il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Stato del capitale al 20 nov 2009
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Gavin Udall come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Philip Matthew Deakin come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ola Tricia-Aramita Barreto-Morley come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di AWT SCALES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S & J REGISTRARS LIMITED | Segretario | Gresham Street Fifth Floor EC2V 7NG London 99 United Kingdom |
| 132600000001 | ||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Amministratore | Gresham Street EC2V 7NG London 99 Uk | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Amministratore | Gresham Street EC2V 7NG London 99 Uk | United Kingdom | British | 146225080002 | |||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Amministratore | Gresham Street EC2V 7NG London 99 Uk | United Kingdom | British | 161583790003 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Amministratore | Gresham Street EC2V 7NG London 99 Uk | United Kingdom | British | 87558180001 | |||||||||
| FOGARTY, Robert Joseph | Segretario | April Cottage Manor Lane Little Comberton WR10 3ER Pershore Worcestershire | British | 17437720002 | ||||||||||
| RYNDYCZ, Mark | Segretario | 26 Kilmorie Road WS11 7HZ Cannock Shrophire | British | 98930470001 | ||||||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Segretario nominato | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 | |||||||||||
| BOWE, Gerald Grant | Amministratore | 85 Pasquaney Lane Bridgewater Nh 03222 Usa | American | 86912720003 | ||||||||||
| CASTLE, David Rayner | Amministratore | 47 Frederick Road Edgbaston B15 1HN Birmingham | American | 86859030001 | ||||||||||
| CASTLE, David | Amministratore | 1344 Oak Beach Fairmount Minnesota 56031 FOREIGN Usa | American | 59141790001 | ||||||||||
| COOPER, Timothy John | Amministratore | 38 Grosvenor Close Four Oaks Sutton Coalfield B75 6RP Birmingham West Midlands | British | 145948190001 | ||||||||||
| CRAMER, Carl, Mr. | Amministratore | 2 Little Dormers South Park Crescent SL9 8HJ Gerrards Cross | United Kingdom | British | 92710960001 | |||||||||
| EVANS, Roger William | Amministratore | The Oaks Main Street Peasmarsh TN31 6SX Rye East Sussex | British | 15546750002 | ||||||||||
| GUNNING, Laurence Patrick | Amministratore | Bushey Cottage High Street, Chipstead TN13 2RW Sevenoaks Kent | Irish | 45213690002 | ||||||||||
| MCCANN, John J | Amministratore | 141 Blackstone Blvd Providence R I 02906 Usa | American | 68980260001 | ||||||||||
| RYNDYCZ, Mark | Amministratore | 26 Kilmorie Road WS11 7HZ Cannock Shrophire | United Kingdom | British | 98930470001 | |||||||||
| UDALL, Gavin | Amministratore | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 83889580001 | |||||||||
| WILKINSON, Richard | Amministratore | 72 Causey Farm Road B63 1EL Halesowen West Midlands | British | 145948210001 | ||||||||||
| HUNTSMOOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008150001 | |||||||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 |
AWT SCALES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Creato il 13 giu 2000 Consegnato il 20 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future monies and liabilities due or to become due from the company or/any other company named therein to the chargee under or in connection with any loan document or specified hedge agreement (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of deposit supplemental to a lease date 18TH may 1987 | Creato il 08 giu 1999 Consegnato il 12 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease | |
Brevi particolari All interest paid from time to time standing to the credit of an interest bearing account opened in the name of the company with a bank or other institution of the company's choosing. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of deposit | Creato il 10 mag 1999 Consegnato il 14 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the charge under a lease dated 29 may 1996 | |
Brevi particolari The deposit sum of £2,937. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter with endorsement | Creato il 11 mar 1999 Consegnato il 17 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date or on any other account | |
Brevi particolari £5,000 being the "deposited sum" as defined in the letter. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 mag 1998 Consegnato il 13 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company,formerly known as swt limited,to the chargee under or in connection with the credit agreement or any of the other loan documents | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0