GORSEWAY CARE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GORSEWAY CARE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03493611 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GORSEWAY CARE LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GORSEWAY CARE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 3rd Floor The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GORSEWAY CARE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LAWGRA (NO.470) LIMITED | 16 gen 1998 | 16 gen 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GORSEWAY CARE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per GORSEWAY CARE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo | 2 pagine | PSC08 | ||||||||||
Cessazione di Barchester Healthcare Homes Limited come persona con controllo significativo il 16 ott 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 034936110003 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 034936110004 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 gen 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Patrick O'reilly come segretario in data 03 apr 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Patrick O'reilly come amministratore in data 03 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Dr Mark Antony Hazlewood il 27 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Pete Calveley il 28 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Suite 304, Third Floor, Design Centre East Chelsea Harbour London SW10 0XF a 3rd Floor the Aspect Finsbury Square London EC2A 1AS in data 08 mar 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Portal come segretario in data 05 ott 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian John Portal come amministratore in data 05 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 034936110004, creata il 01 ago 2016 | 46 pagine | MR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Dr Mark Antony Hazlewood il 01 ago 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian John Portal il 01 ago 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Ian Portal il 01 ago 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GORSEWAY CARE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'REILLY, Michael Patrick | Segretario | The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London 3rd Floor United Kingdom | 230766770001 | |||||||
| CALVELEY, Pete | Amministratore | The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 188462950001 | |||||
| HAZLEWOOD, Dr Mark Antony, Dr | Amministratore | The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 186525550001 | |||||
| O'REILLY, Michael Patrick | Amministratore | The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 40241900001 | |||||
| BELCHER, Margaret Ann | Segretario | 67 Evelyn Crescent Upper Shirley SO15 5JF Southampton Hampshire | British | 113378310001 | ||||||
| BURNS, Jacqueline | Segretario | 14 St. Tristan Close Locks Heath SO31 6XR Southampton Hampshire | British | 120981640001 | ||||||
| HATHER, Jon | Segretario | Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201, The Chambers | British | 153240350001 | ||||||
| KING, Felicity | Segretario | Stondtorre Knowle Road, Lustleigh TQ13 9SP Newton Abbot | British | 114949930001 | ||||||
| MATTHEWS, Ian David | Segretario | Tiriana 1 Glen Eyre Drive SO16 3NQ Southampton Hampshire | British | 58366330001 | ||||||
| PORTAL, Ian | Segretario | Third Floor, Design Centre East Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 304, United Kingdom | 165059530001 | |||||||
| WATSON, David | Segretario | 2a Jessie Road PO9 3TH Havant Hampshire | British | 125470210001 | ||||||
| LAWGRAM SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | More London Riverside SE1 2AU London 4 | 900004760001 | |||||||
| BURLEY, Michael Sherer | Amministratore | Burnham House 112 Station Road GU33 7AQ Liss Hampshire | England | British | 55012850002 | |||||
| BURNS, Jacqueline | Amministratore | 14 St. Tristan Close Locks Heath SO31 6XR Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 120981640001 | |||||
| DUNCAN, David Gregor | Amministratore | Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201, The Chambers | United Kingdom | British | 97755760001 | |||||
| GIBSON, Linda Anne | Amministratore | 44 Hillfield Road Selsey PO20 0LF Chichester West Sussex | England | British | 71790080001 | |||||
| GILHOOLEY, James | Amministratore | 6 The Timbers Catisfield PO15 5NB Fareham Hampshire | England | British | 92217250001 | |||||
| HATHER, Jon | Amministratore | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 68848420006 | |||||
| HOLMES, Peter Herbert John | Amministratore | 12 St Tristan Close Locks Heath SO31 6XR Southampton Hampshire | England | British | 23336890002 | |||||
| JAMES, Eric John | Amministratore | Appt 21 Gorseway 354 Sea Front PO11 0BA Hayling Island Hampshire | British | 62272910001 | ||||||
| JONES, Roy Frederick | Amministratore | Lychgate 26 Bound Lane Mengham PO11 9HU Hayling Island Hampshire | British | 58366510001 | ||||||
| KING, Felicity Joan | Amministratore | Knowle Road Lustleigh TQ13 9SP Newton Abbot Stondtorre Devon | United Kingdom | British | 137518090001 | |||||
| MILLS, Robert William | Amministratore | Selbourne Avenue New Haw KT15 3RD Addlestone 71 Surrey | England | British | 163810350001 | |||||
| MUNDAY, Richard | Amministratore | 53 Commonside PO10 8TD Emsworth Hampshire | British | 76220760002 | ||||||
| PARSONS, Michael Dennis | Amministratore | Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201, The Chambers | United Kingdom | British | 44895330007 | |||||
| PORTAL, Ian John | Amministratore | Third Floor, Design Centre East Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 304, United Kingdom | United Kingdom | British | 165696110001 | |||||
| RIDLEY, Derek Edward | Amministratore | 12 St Aubins Park PO11 0HQ Hayling Island Hampshire | British | 58366580001 | ||||||
| STANDEN, Shelagh | Amministratore | 23 The Strand Hayling Island PO11 9UB Havant Hampshire | British | 73882260001 | ||||||
| STREET, Stephen Gregory | Amministratore | 10 English Street Mile End E3 4TA London United Kingdom | British | 47656020001 | ||||||
| SULLIVAN, Terence William | Amministratore | 27 Alexandra Avenue PO11 9AL Hayling Island Hampshire | British | 58366670001 | ||||||
| SWEETINBURGH, Simon David | Amministratore | 3 Park Mead SN16 0DZ Malmesbury Wiltshire | United Kingdom | British | 116260690001 | |||||
| VILKAS, Margaret Ann | Amministratore | 107 Fortunes Way PO9 3LY Havant Hampshire | England | British | 68133750001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GORSEWAY CARE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barchester Healthcare Homes Limited | 06 apr 2016 | Third Floor, Design Centre East Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 304, United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GORSEWAY CARE LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 16 ott 2018 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
GORSEWAY CARE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 01 ago 2016 Consegnato il 08 ago 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 18 dic 2013 Consegnato il 20 dic 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 lug 2010 Consegnato il 23 lug 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 ago 2000 Consegnato il 25 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future indebtedness of hemitage to the finance parties (as defined) and in relation to this debenture | |
Brevi particolari Floating charge the undertaking and all its property assets revenues and rights present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0