NPS (UK5) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNPS (UK5) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03495019
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NPS (UK5) LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova NPS (UK5) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NPS (UK5) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NORTHGATE PUBLIC SECTOR LIMITED28 nov 200828 nov 2008
    ANITE PUBLIC SECTOR LIMITED02 feb 200002 feb 2000
    IMASYS LIMITED16 feb 199816 feb 1998
    IMASYS (LOCAL GOVERNMENT) LIMITED14 gen 199814 gen 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di NPS (UK5) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per NPS (UK5) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW a 15 Canada Square London E14 5GL in data 03 lug 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 giu 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018

    2 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2017, non revisionato

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    5 pagineAA

    Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 gen 2016

    Stato del capitale al 04 gen 2016

    • Capitale: GBP 61,686,134.332
    SH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed northgate public sector LIMITED\certificate issued on 16/06/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name16 giu 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 09 giu 2015

    RES15

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    legacy

    pagineANNOTATION

    Chi sono gli amministratori di NPS (UK5) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Segretario
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Segretario
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Segretario
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Segretario
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    Segretario
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    British128558470001
    SADLER, John Michael
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Segretario
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78431540001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHAH, Bijal
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    Segretario
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    British116421860001
    TIDSALL, David Peter Charles
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    British3854790001
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Segretario
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    British14373460003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    BASS, Neil Anthony
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    Amministratore
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    EnglandBritish70199330002
    BEATON, Richard L'Estrange
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish97291590001
    BODHA, James Sanjay
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    EnglandBritish93657140001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    GIBSON, John Leonard
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    Amministratore
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    British104554430001
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Amministratore
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    United KingdomBritish32877720003
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Amministratore
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    British118771650001
    KINGSWOOD, Michael
    Holm Farm
    Catesby End Hellidon
    NN11 6GB Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    Holm Farm
    Catesby End Hellidon
    NN11 6GB Daventry
    Northamptonshire
    British123863990001
    MARRISON, Michael Anthony
    10 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    10 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish67938980003
    MCCANN, James
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    British69923680001
    MEADEN, David John
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding
    Estate, Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding
    Estate, Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Amministratore
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritish93738770001
    SLOGGETT, David Raymond, Dr
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    British34112730001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    TAIT, Ian
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    Amministratore
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    United KingdomBritish76976490001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77284710002
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    British14373460003
    WOOTTON BEARD, Timothy
    Catkins
    Westhill Road North, South Wonston
    SO21 3HJ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Catkins
    Westhill Road North, South Wonston
    SO21 3HJ Winchester
    Hampshire
    British93274500001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NPS (UK5) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06526803
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NPS (UK5) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 27 feb 2009
    Consegnato il 09 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 09 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Creato il 16 feb 2007
    Consegnato il 01 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Creato il 15 feb 2007
    Consegnato il 01 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 28 nov 2006
    Consegnato il 30 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Creato il 28 feb 2006
    Consegnato il 02 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of deposit
    Creato il 18 dic 2003
    Consegnato il 19 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Creato il 09 dic 2002
    Consegnato il 13 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 10 mag 2002
    Consegnato il 24 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 24 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 08 dic 2000
    Consegnato il 21 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise)
    Brevi particolari
    The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995)
    Creato il 09 apr 1999
    Consegnato il 21 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 gen 1998
    Consegnato il 10 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NPS (UK5) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 giu 2019Inizio della liquidazione
    02 ott 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0