NPS (UK5) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NPS (UK5) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03495019 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NPS (UK5) LIMITED?
- Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
Dove si trova NPS (UK5) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NPS (UK5) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| NORTHGATE PUBLIC SECTOR LIMITED | 28 nov 2008 | 28 nov 2008 |
| ANITE PUBLIC SECTOR LIMITED | 02 feb 2000 | 02 feb 2000 |
| IMASYS LIMITED | 16 feb 1998 | 16 feb 1998 |
| IMASYS (LOCAL GOVERNMENT) LIMITED | 14 gen 1998 | 14 gen 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NPS (UK5) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per NPS (UK5) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW a 15 Canada Square London E14 5GL in data 03 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2017, non revisionato | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed northgate public sector LIMITED\certificate issued on 16/06/15 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 11 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
legacy | pagine | ANNOTATION | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NPS (UK5) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
| CALLAGHAN, Stephen James | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 201347710052 | |||||||||
| COUTTS, Cheryl Jane | Segretario | 6 Esmond Road W4 1JQ Chiswick London | British | 12016130002 | ||||||||||
| COX, Melanie Rachel | Segretario | 1 The Green Bisham SL7 1RY Marlow Buckinghamshire | British | 96139050001 | ||||||||||
| HEMMING, Vivienne Ruth | Segretario | 25 Saint Johns Road OX10 9AW Wallingford Oxon | British | 41962390006 | ||||||||||
| HUMPHREY, Christopher John | Segretario | Well House School Lane, Northend BA1 7EP Bath Somerset | British | 32877720003 | ||||||||||
| RICHARDSON, John David | Segretario | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire | British | 128558470001 | ||||||||||
| SADLER, John Michael | Segretario | 14 Highlands Close SL9 0DR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78431540001 | ||||||||||
| SCHENCK, Daniel William | Segretario | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||||||
| SHAH, Bijal | Segretario | 24 Dorset Mews Finchley N3 2BN London | British | 116421860001 | ||||||||||
| TIDSALL, David Peter Charles | Segretario | 50 Anglesey Avenue Cove GU14 8SQ Farnborough Hampshire | British | 3854790001 | ||||||||||
| WENMAN, Nicholas Edward | Segretario | Three Gates 40a Guildown Road GU2 5EY Guildford Surrey | British | 14373460003 | ||||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | 165900220001 | |||||||||
| BASS, Neil Anthony | Amministratore | 31 Archery Fields RG29 1AE Odiham Hampshire | England | British | 70199330002 | |||||||||
| BEATON, Richard L'Estrange | Amministratore | Prestbury Hall The Village SK10 4BN Prestbury Cheshire | England | British | 97291590001 | |||||||||
| BODHA, James Sanjay | Amministratore | Rook How 22 Elm Tree Road WA13 0NB Lymm Cheshire | England | British | 93657140001 | |||||||||
| COLL, Andrew | Amministratore | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 237260100001 | |||||||||
| GIBSON, John Leonard | Amministratore | Ivydene Delly End OX29 9XD Hailey Oxfordshire | British | 104554430001 | ||||||||||
| HUMPHREY, Christopher John | Amministratore | Well House School Lane, Northend BA1 7EP Bath Somerset | United Kingdom | British | 32877720003 | |||||||||
| HUNT, Simon Anthony | Amministratore | Apt 31 21 Sheldon Square Paddington Central W2 6DS London | British | 118771650001 | ||||||||||
| KINGSWOOD, Michael | Amministratore | Holm Farm Catesby End Hellidon NN11 6GB Daventry Northamptonshire | British | 123863990001 | ||||||||||
| MARRISON, Michael Anthony | Amministratore | 10 Armistead Way Cranage CW4 8FE Crewe Cheshire | England | British | 67938980003 | |||||||||
| MCCANN, James | Amministratore | 32 Carter Close SL4 3QX Windsor Berkshire | British | 69923680001 | ||||||||||
| MEADEN, David John | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 193740420001 | |||||||||
| NOBLE, Ian Michael | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 199843940001 | |||||||||
| ROWLEY, Stephen Paul, Mr. | Amministratore | Hadleigh 16 Sandown Road KT10 9TU Esher Surrey | United Kingdom | British | 93738770001 | |||||||||
| SLOGGETT, David Raymond, Dr | Amministratore | 12 Mcnaughton Close GU14 0PX Farnborough Hampshire | British | 34112730001 | ||||||||||
| STIER, John Robert | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78901530003 | |||||||||
| STONE, Christopher Michael Renwick | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 66955690003 | |||||||||
| TAIT, Ian | Amministratore | Field House Evesham Road WR10 2QR Fladbury Worcestershire | United Kingdom | British | 76976490001 | |||||||||
| TYRRELL, Simon Robert Edgar | Amministratore | Larks 15 Burstead Close KT11 2NL Cobham Surrey | England | British | 77284710002 | |||||||||
| WENMAN, Nicholas Edward | Amministratore | Three Gates 40a Guildown Road GU2 5EY Guildford Surrey | British | 14373460003 | ||||||||||
| WOOTTON BEARD, Timothy | Amministratore | Catkins Westhill Road North, South Wonston SO21 3HJ Winchester Hampshire | British | 93274500001 | ||||||||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NPS (UK5) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nps (Uk2) Limited | 06 apr 2016 | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NPS (UK5) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession | Creato il 27 feb 2009 Consegnato il 09 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006 | Creato il 16 feb 2007 Consegnato il 01 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006 | Creato il 15 feb 2007 Consegnato il 01 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 28 nov 2006 Consegnato il 30 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002 | Creato il 28 feb 2006 Consegnato il 02 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of deposit | Creato il 18 dic 2003 Consegnato il 19 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The deposit. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus letter of set-off | Creato il 09 dic 2002 Consegnato il 13 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating security document | Creato il 10 mag 2002 Consegnato il 24 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating security document | Creato il 08 dic 2000 Consegnato il 21 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise) | |
Brevi particolari The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995) | Creato il 09 apr 1999 Consegnato il 21 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 gen 1998 Consegnato il 10 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
NPS (UK5) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0