PERFORMANCE MOTOR YACHTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PERFORMANCE MOTOR YACHTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03497098 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PERFORMANCE MOTOR YACHTS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PERFORMANCE MOTOR YACHTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o BAKER & MCKENZIE 100 New Bridge Street EC4V 6JA London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PERFORMANCE MOTOR YACHTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INGLEBY (1056) LIMITED | 22 gen 1998 | 22 gen 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PERFORMANCE MOTOR YACHTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per PERFORMANCE MOTOR YACHTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 16 lug 2013
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di John Charles Pfeifer come amministratore in data 13 mar 2013 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Coultate come amministratore in data 13 mar 2013 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 22 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Marsha Theresa Vaughn il 04 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Judith Zelisko il 27 set 2011 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Charles Pfeifer il 27 set 2011 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Stephen Coultate il 27 set 2011 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Christopher James O'connor come amministratore in data 21 set 2011 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Marsha Theresa Vaughn come segretario in data 30 ago 2011 | 3 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Walker Bonham come segretario in data 30 ago 2011 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Walker Bonham come amministratore in data 30 ago 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Whitehouse Road Kidderminster Worcestershire DY10 1HT in data 08 set 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 ago 2011
| 9 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 5 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Mr Christopher James O'connor come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PERFORMANCE MOTOR YACHTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHN, Marsha Theresa | Segretario | c/o Brunswick Corp In Field Corp Lake Forrest Illinois 60945 United States | British | 163175600001 | ||||||
| VAUGHN, Marsha Theresa | Amministratore | c/o C/O Brunswick Corp N. Field Court 60045 Lake Forest 1 Illinois Usa | United States | American | 102767420001 | |||||
| ZELISKO, Judith Pistaki | Amministratore | c/o C/O Brunswick Coporation 1n. Field Court Lake Forest Illinois 60045 Usa | United States | American | 188776480001 | |||||
| BONHAM, Robert Walker | Segretario | c/o Baker & Mckenzie New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom | British | 112681180001 | ||||||
| NAYLOR, David | Segretario | 17 Beaubrook Gardens DY8 5QJ Wordsley West Midlands | British | 92494310001 | ||||||
| RIDLEY, John Henry Wallace | Segretario | 52 Park Lane DY12 2EU Bewdley Worcestershire | British | 1746550001 | ||||||
| WAINWRIGHT, Gerard Bernard | Segretario | Hargrove Wall Under Heywood SY6 7DP Church Stretton Shropshire | British | 48897350001 | ||||||
| INGLEBY NOMINEES LIMITED | Segretario nominato | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
| BONHAM, Robert Walker | Amministratore | c/o Baker & Mckenzie New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom | England | British | 112681180001 | |||||
| COULTATE, Stephen | Amministratore | c/o C/O Brunswick Corporation 1n. Field Court Lake Forest Illinois | United Kingdom | British | 113160780001 | |||||
| EALES, Darryl Charles | Amministratore | 7 Sycamore Drive Hollywood B47 5QX Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | 2886080001 | |||||
| HORNER, Michael Ralph | Amministratore | 907 E North Path Wheaton Illinois 60187 Usa | American | 94183930001 | ||||||
| MCCOY, Dustan | Amministratore | 236 East North Avenue 60044 Lake Bluff Illinois Usa | Us Citizen | 75832550007 | ||||||
| MEYER, James Richard | Amministratore | Whitehouse Road Kidderminster DY10 1HT Worcestershire | Usa | American | 123729240002 | |||||
| MILES, Richard Michael | Amministratore | Tredington House Tredington CV36 4NG Shipston On Stour Warwickshire | British | 2390750002 | ||||||
| O'CONNOR, Christopher James | Amministratore | c/o Baker & Mckenzie New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom | England | British | 126446780001 | |||||
| PFEIFER, John Charles | Amministratore | c/o C/O Brunswick Corporation 1n. Field Court Lake Forest Illinois 60045 | Belium | Canadian | 147486950001 | |||||
| REYNOLDS, Kevin Paul | Amministratore | 19 York Street Harborne B17 0HG Birmingham West Midlands | British | 101625190001 | ||||||
| RIDLEY, John Henry Wallace | Amministratore | 52 Park Lane DY12 2EU Bewdley Worcestershire | British | 1746550001 | ||||||
| RISON, Robin Donald | Amministratore | 43 Kelmscott Road B17 8QW Birmingham West Midlands | England | British | 13750730002 | |||||
| SLADNICK, Clifford | Amministratore | 343 Old Green Bay Road Glencre Illinois 60022 Usa | Usa | 76026180001 | ||||||
| VON SYDOW, Patrik Christian | Amministratore | Loxley Road CV37 7DT Stratford Upon Avon 154a Warwickshire | England | Swedish | 102016580001 | |||||
| WAINWRIGHT, Gerard Bernard | Amministratore | Hargrove Wall Under Heywood SY6 7DP Church Stretton Shropshire | United Kingdom | British | 48897350001 | |||||
| INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
PERFORMANCE MOTOR YACHTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 20 giu 1998 Consegnato il 25 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as ingleby (1056) limited) to the chargee as security trustee for the finance parties as defined in the debenture (the "security trustee") on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Cash collateral charge | Creato il 20 giu 1998 Consegnato il 25 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as ingleby (1056) limited) to the chargee as security trustee for the finance parties as defined in the charge (the "security trustee ") on any account whatsoever | |
Brevi particolari The debt or debts now or hereafter owing to the company (in whatever currency denominated) by the security trustee on an account k/a the cash collateral account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0